BLSSP (PHC 4) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BLSSP (PHC 4) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04104052 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BLSSP (PHC 4) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BLSSP (PHC 4) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour BLSSP (PHC 4) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 déc. 2019 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 avr. 2019 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 8-12 York Gate London NW1 4QG England à 55 Baker Street London W1U 7EU le 11 mai 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2017 au 24 mai 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 041040520003 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Cessation de Blssp Property Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mai 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Crispin James De Grave Gandy en tant qu'administrateur le 18 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Saul Jonathan Forman en tant qu'administrateur le 18 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de York House 45 Seymour Street London W1H 7LX à 8-12 York Gate London NW1 4QG le 26 mai 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Benjamin Toby Grose en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Nelson en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Bryan Lewis en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Hursh Shah en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Benjamin Toby Grose en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Luke Thomas Francis en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Dean Clegg en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Martyn Stephen Burke en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BLSSP (PHC 4) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAN, Saul Jonathan | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 165272690001 | |||||||||
| GANDY, Crispin James De Grave | Administrateur | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 195535830001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Secrétaire | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secrétaire | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAM, Shenol | Administrateur | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Administrateur | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Administrateur | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BIRCH, John Matthew | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Administrateur | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Administrateur | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Administrateur | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000002 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Administrateur | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Administrateur | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HOORN, Antony John Van Der | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 170891040001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Administrateur | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Administrateur | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Stephen Howard | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 185276290002 | |||||||||
| NELSON, Sarah | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 220620220001 | |||||||||
| O'LOAN, David Arthur | Administrateur | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 137230800001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BLSSP (PHC 4) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blssp Property Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Oui | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BLSSP (PHC 4) LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 18 janv. 2018 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
BLSSP (PHC 4) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 24 mai 2017 Livré le 26 mai 2017 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 24 mai 2017 Livré le 25 mai 2017 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Borrower deed of charge | Créé le 28 févr. 2006 Livré le 09 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Créé le 20 juin 2001 Livré le 06 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
BLSSP (PHC 4) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0