BLSSP (PHC 30) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLSSP (PHC 30) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04104067
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLSSP (PHC 30) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe BLSSP (PHC 30) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Duff & Phelps The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BLSSP (PHC 30) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BLSSP (PHC 30) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    19 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 11-12 st. James's Square, Suite 2 London SW1Y 4LB England à C/O Duff & Phelps the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 24 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 041040670007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 041040670006 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    34 pagesAA

    Cessation de la nomination de Nicholas John Bland en tant que directeur le 16 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sunil Masson le 16 juil. 2018

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sunil Masson le 16 juil. 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Julius Manuel Bozzino en tant qu'administrateur le 16 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Winchester House Mailstop 428 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB à 3rd Floor 11-12 st. James's Square, Suite 2 London SW1Y 4LB le 20 juil. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    32 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 nov. 2015

    État du capital au 03 nov. 2015

    • Capital: GBP 325,000
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 041040670007, créée le 29 sept. 2015

    30 pagesMR01

    Inscription de la charge 041040670006, créée le 29 sept. 2015

    46 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de BLSSP (PHC 30) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSON, Sunil
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Duff & Phelps
    Secrétaire
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Duff & Phelps
    British193949870001
    BOZZINO, Julius Manuel
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Duff & Phelps
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Duff & Phelps
    United KingdomBritish,Director103781140001
    MASSON, Sunil
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Duff & Phelps
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Duff & Phelps
    United KingdomBritishBanker76262480002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Administrateur
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Administrateur
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritishChartered Surveyor175617500001
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119073370001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director191027500001
    BLAND, Nicholas John
    11-12 St. James's Square, Suite 2
    SW1Y 4LB London
    3rd Floor
    England
    Administrateur
    11-12 St. James's Square, Suite 2
    SW1Y 4LB London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritishBanker140309730001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152531940004
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director189632520001
    COWEN, Geraint Jamie
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director141040000002
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GILDING, Sally Margaret
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House Mailstop 428
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House Mailstop 428
    UkAustralianBanker193652740001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HOORN, Antony John Van Der
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director170891040001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEWIS, Bryan John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58257940003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    PRIOR, Vincent John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Property Investment173101580001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BLSSP (PHC 30) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    03 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    BLSSP (PHC 30) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 sept. 2015
    Livré le 05 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank
    Transactions
    • 05 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 sept. 2015
    Livré le 05 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Sainsburys supermaroket 11 castle bridge road nottingham f/h t/no's NT208857, NT307128 abd NT332798. L/h t/no's NT266954 and NT337162.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank
    Transactions
    • 05 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 05 avr. 2013
    Livré le 23 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land lying to the north east of castle brdige road nottingham t/no NT337162,l/h land and buildings on the north east side of castle bridge road castle boulevard nottingham t/no NT266954 f/h land and buildings on the north side of castle bridge road castle boulevard nottingham t/no NT208857 and f/h land lying to the north of castle bridge road castle boulevard nottingham t/no's NT332798 and NT307128 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited ("Borrower Security Trustee")
    Transactions
    • 23 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Borrower deed of charge
    Créé le 28 févr. 2006
    Acquis le 05 avr. 2013
    Livré le 16 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in the existing nominee property assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited ("Borrower Security Trustee")
    Transactions
    • 16 avr. 2013Enregistrement d'une acquisition (MG06)
    • 24 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Borrower deed of charge
    Créé le 28 févr. 2006
    Livré le 09 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    Transactions
    • 09 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental borrower deed of charge supplemental to the borrower deed of charge dated 20 june 2001
    Créé le 15 août 2003
    Livré le 28 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all of its interest in the charged additional mortgaged property. All its rights under the agreement and declaration of trust and deed of instruction and indemnity. All fixtures owned by it at the charged additional mortgaged property and its interest in any fixtures in its possession. Its interest in all benefits in respect of the insurances to the extent that they relate to the charged additional mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as Secured Note Trustee
    Transactions
    • 28 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar")
    Créé le 20 juin 2001
    Livré le 06 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as the Trustee Pursuant to Thesecured Note Trust Deed (The "Secured Note Trustee") on Trust for Itself and the Other Borrowersecured Parties
    Transactions
    • 06 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BLSSP (PHC 30) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2019Commencement of winding up
    22 sept. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0