CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED

CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 04105878
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières
    • Gestion de la propriété résidentielle (98000) / Activités des ménages employeurs ; activités de production de biens et services non différenciées des ménages pour usage propre

    Où se situe CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Myriad House 33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHELMER HOUSING PARTNERSHIP07 nov. 200007 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Combined form b/z convert to rs
    1 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 05/10/2017
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 041058780021, créée le 13 déc. 2018

    19 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Ian Fisher le 17 déc. 2018

    2 pagesCH01

    Inscription de la charge 041058780020, créée le 09 nov. 2018

    26 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Robin John Tebbutt en tant que directeur le 09 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Karen Angela Mayhew en tant qu'administrateur le 04 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    81 pagesAA

    Nomination de Mr Anthony Charles Goymour en tant qu'administrateur le 04 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Keith John Andrew en tant que directeur le 04 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 041058780019, créée le 09 mai 2018

    33 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 07 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Barbara Ann Richardson en tant que directeur le 23 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jeremy John Jacobs en tant que secrétaire le 27 févr. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stuart Stackhouse en tant que secrétaire le 27 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Barbara Ann Richardson en tant qu'administrateur le 05 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Stephen George Bennett en tant qu'administrateur le 05 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Marc Noaro en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Nicola Mary Sawford en tant qu'administrateur le 05 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter John Cogan en tant qu'administrateur le 05 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Marc Noaro en tant qu'administrateur le 05 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ronald William Goodyear en tant que directeur le 05 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Ives en tant que directeur le 05 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ursula Mary Heelis en tant que directeur le 05 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JACOBS, Jeremy John
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Secrétaire
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    243669260001
    BENNETT, Stephen George
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishChartered Secretary15889420001
    BRAITHWAITE, Rosemary Elisabeth
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    EnglandBritishFinancial Controller176700580001
    COGAN, Peter John
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishRetail Customer Operations Director, Thames Water239304470001
    FISHER, Neil Ian
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishFinance Director206252780001
    GOYMOUR, Anthony Charles
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishSocial Housing Treasury Consultant186363960001
    MAYHEW, Karen Angela
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishChief Executive Housing Association161930610001
    NOARO, Marc
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishChief Customer Officer, Eurostar International239304280001
    SAWFORD, Nicola Mary
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    EnglandBritishNon Executive Director82715400001
    WANMER, Joanna Rebecca
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    EnglandBritishLocal Government Officer191831420001
    BEILEY, Robert James
    30 Keeling House
    Claredale Street
    E2 6PG London
    Secrétaire
    30 Keeling House
    Claredale Street
    E2 6PG London
    BritishSolicitor85927990001
    STACKHOUSE, Stuart
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Secrétaire
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    BritishChief Executive80779170001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    190 Strand
    WC2R 1JN London
    Secrétaire
    190 Strand
    WC2R 1JN London
    67466840001
    AMOR, Dawn Elizabeth
    80 Longacre
    CM1 3BJ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    80 Longacre
    CM1 3BJ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishService Manager80252550002
    ANDREW, Keith John
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    EnglandBritishBusiness & Management Consultant59279260001
    ANDREW, Keith John
    3 Petersfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    3 Petersfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishBusiness Adviser59279260001
    BEILEY, Robert James
    30 Keeling House
    Claredale Street
    E2 6PG London
    Administrateur
    30 Keeling House
    Claredale Street
    E2 6PG London
    BritishSolicitor85927990001
    CARTER, Dawn
    6 Elm Close
    Broomfield
    CM1 7DY Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    6 Elm Close
    Broomfield
    CM1 7DY Chelmsford
    Essex
    BritishRetired93422740001
    COURET, Jonathan Graham George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishSenior Executive88722740002
    DEAN, Martin Hamilton
    23 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    23 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishAssociate Lecturer62469810001
    DENSTON, Bob Frederick
    3 Hawthorn Walk
    CM3 5TX South Woodham Ferrers
    Essex
    Administrateur
    3 Hawthorn Walk
    CM3 5TX South Woodham Ferrers
    Essex
    BritishRetired Mortgage Advisor122005380001
    DEVANE, John
    54 Foxholes Road
    Great Baddow
    CM2 7HS Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    54 Foxholes Road
    Great Baddow
    CM2 7HS Chelmsford
    Essex
    BritishFurther Education Manager80252490001
    EVANS, Roy Edward
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    EnglandEnglishCivil Servant177277310001
    FRENCH, Paul George David
    2 Springfield Place
    Springfield Green
    CM1 7ZA Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    2 Springfield Place
    Springfield Green
    CM1 7ZA Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishBanker80252740001
    FULLER, Terence William
    39 Prince William Way
    CB2 4SZ Sawston
    Cambridgeshire
    Administrateur
    39 Prince William Way
    CB2 4SZ Sawston
    Cambridgeshire
    BritishPartnering Director87804550001
    GINN, Ron
    13 Saint Nazaire Road
    CM1 2EG Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    13 Saint Nazaire Road
    CM1 2EG Chelmsford
    Essex
    BritishRetired80252310001
    GOLD, David Ronald
    2 Essex Avenue
    CM1 4AQ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    2 Essex Avenue
    CM1 4AQ Chelmsford
    Essex
    BritishRetired Sales & Marketing Exec125762260001
    GOODYEAR, Ronald William
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    EnglandBritishRetired Publican174968330001
    GRAHAM, Lesley Elizabeth
    6 Melbourne Parade
    CM1 2DW Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    6 Melbourne Parade
    CM1 2DW Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director103106810001
    GREEN, Colleen
    23 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    23 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishRelationship Manager Lending100499770002
    GREGORY, Helen Virginia
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    EnglandBritishHousing Consultant Trainer107333150001
    GULLIVER, Neil
    150b Wood Street
    CM2 8BN Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    150b Wood Street
    CM2 8BN Chelmsford
    Essex
    BritishProbation Officer80252670001
    HEELIS, Ursula Mary
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    Administrateur
    33 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    England
    United KingdomBritishRetired134271140001
    HEYWOOD, Andrew Richard
    23 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    23 Springfield Lyons Approach
    Springfield
    CM2 5LB Chelmsford
    Myriad House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishHousing Policy/Finance Consultant161940160001
    HILL, John
    18 Pryors Road
    Galleywood
    CM2 8SA Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    18 Pryors Road
    Galleywood
    CM2 8SA Chelmsford
    Essex
    BritishRetired80252690001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    07 avr. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    CHELMER HOUSING PARTNERSHIP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 13 déc. 2018
    Livré le 21 déc. 2018
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Birch Lodge Canewdon Limited
    Transactions
    • 21 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 nov. 2018
    Livré le 26 nov. 2018
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Persimmon Homes Limited
    • Grangewood Park (Burnham on Crouch) Residents Management Company Limited
    Transactions
    • 26 nov. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 mai 2018
    Livré le 14 mai 2018
    En cours
    Brève description
    The freehold property known as 2-9 (inclusive), 11, 13, 15 and 17-29 (odd) henman way, brentwood, essex, CM14 4EZ and 1 henman way and 29-89 (odd) little highwood way, brentwood, essex, CM14 4RJ (formerly known as land lying to the south of ongar road) registered at the land registry with title number EX861006. To see all charges, please refer to schedule 1 of the of the charging document attached to this form.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited as Trustee for Itself and the Beneficiaries (Security Trustee)
    Transactions
    • 14 mai 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 sept. 2017
    Livré le 28 sept. 2017
    En cours
    Brève description
    F/H plots 144, 233-237, 254-260 and 268-281 as further detailed in the legal charge.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Persimmon Homes Limited
    Transactions
    • 28 sept. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 25 août 2017
    Livré le 01 sept. 2017
    En cours
    Brève description
    Part of that freehold land comprising of plots 108-113 and 150-198 as are shown edged red on the plan being part of the title number EX926653.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Persimmon Homes Limited
    Transactions
    • 01 sept. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 déc. 2016
    Livré le 15 déc. 2016
    En cours
    Brève description
    The whole of the land and building known as 1-8 (inclusive) belvedere terrace at 71 west belvedere, chelmsford, CM3 4RF registered at the land registry with title number EX701262. To see all chargers, please see schedule 1 of the supplemental deed attached to this form.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries (Security Trustee)
    Transactions
    • 15 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 déc. 2016
    Livré le 14 déc. 2016
    En cours
    Brève description
    The whole of the land and building known as 50, 50A, 51, 51A, 52 and 52A, swiss avenue, chelmsford, CM1 2AD registered at the land registry with title number EX709707. To see all charges, please see schedule 1 of the supplemental debenture attached to this form.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Beneficiaries (Security Trustee)
    Transactions
    • 14 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2016
    Livré le 08 déc. 2016
    En cours
    Brève description
    Freehold 7-14 inclusive eddy downs chelmsford title no EX902356 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 sept. 2016
    Livré le 11 oct. 2016
    En cours
    Brève description
    8-15 (incl) albany close chelmsford CM1 2EP. To see all charges, please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 11 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 avr. 2016
    Livré le 14 avr. 2016
    En cours
    Brève description
    1-11 (incl) coopers, the chase boreham chelmsford CM3 3FF. To see all charges,please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 14 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 déc. 2013
    Livré le 10 janv. 2014
    En cours
    Brève description
    F/H property k/a 1-23 (odd) barley lane dunmow (formerly k/a dunmow county infant school the downs dunmow) t/no EX860093, f/h property k/a 41-47 (odd) dennington crescent basildon and 3-11 (inclusive) church terrace basildon t/no EX867835 and f/h property 26-42 (even) edward paxman gardens colchester (formerly k/a land at edward paxman gardens) t/no EX862617 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 10 janv. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Mortgage
    Créé le 15 févr. 2013
    Livré le 21 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the real property being 48-56 (evens) bramble road witham essex t/no EX840595, 69-101 (odds) bramble road witham essex and 44 and 46 bramble road witham essex t/no EX854680 and any fixtures and all related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 22 oct. 2012
    Livré le 01 nov. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right, title and interest from time to time in the real property being 2-30 evens morley house, schoolfield road, west thurrock, essex, 691-707 (odds) london road, west thurrock, essex and 16-24 (evens) schoolfield way, grays, essex t/no ESX850237 for further details of properties charged please refer to the form MG01 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 27 mars 2012
    Livré le 11 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property 1-15 (inc) westminster court borromeo way brentwood essex, 4-10 (evens) and 13-27 (odds) de paul way brentwood essex, and 1-6 edward watson court de paul way brentwood essex t/no EX845331 for full list of properties charged please see form MG01 and any fixture and includes all related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 11 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 18 août 2011
    Livré le 25 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at brookview sandon essex, t/n EX806787 41-81 (odds) arnhem road chelmsford t/n EX800214, 1-4 cumberland court cumberland crescent broomfield chelsford t/n EX360236 EX360332 and EX407830, for details of further properties charged, please refer to form MG01, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 25 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 03 déc. 2010
    Livré le 16 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 1-16 (inclusive) station house gordon road corringham essex t/no. EX276112, l/h 22 chapman place colchester and parking space EX817379, l/h 28 chapman place colchester and parking space EX817386 for details of further properties please see MG01 and any fixtures on or forming part of the property including all related rights see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 16 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 06 oct. 2010
    Livré le 13 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The real property k/a 2-24 (even) harris yard, saffron walden t/no. EX761977, 34-48 (even) 70-82 (even) 81-97 (odd) and 103 shimbrooks great leighs chelmsford t/no. EX795084 EX795085 EX762332 and 10-20 (even) 24-34 (even) and 38-48 (even) 26-48 bond street chelmsford essex t/no. EX824570 and any fixtures on or forming part of the property including all related rights see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 13 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2007
    Livré le 23 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the right, title and interest from time to tiem in and to each of the following assets, the proceeds account, the insurances and all claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 avr. 2007
    Livré le 07 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Various properties as listed on the list with all buildings,fixtures,plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 mars 2002
    Livré le 28 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to each of the following assets the proceeds account the insurances the benefit of all present and future licences the council sales agreements the personal agreement and covenants all agreements all licences all rights and claims by way of floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 28 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 11 mars 2002
    Livré le 28 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all the borrowers right title and interest in the real property being all freehold and leasehold properties in the borough of chelmsford comprised in a transfer between chelmsford borough council and the borrower pursuant to the council sale agreement and any fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 28 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0