WORKSPACE 9 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WORKSPACE 9 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04106607 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WORKSPACE 9 LIMITED ?
Adresse du siège social | Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WORKSPACE 9 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour WORKSPACE 9 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE à Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE le 01 nov. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Jameson Paul Hopkins en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Harry Platt en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* le 04 août 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Harry Platt le 19 oct. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Colin Clemett le 19 oct. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Graham Colin Clement le 24 sept. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WORKSPACE 9 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARFORA, Carmelina | Secrétaire | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | 150287080001 | |||||||
CLEMETT, Graham Colin | Administrateur | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | Director | 123744930001 | ||||
HOPKINS, Jameson Paul | Administrateur | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | Director | 79842180002 | ||||
BINNS, Adam | Secrétaire | 15 Langhams Way Wargrave RG10 8AX Reading Berkshire | British | Accountant | 113638490001 | |||||
CHAPMAN, Paul Stephen | Secrétaire | 13 Southbourne Hayes BR2 7NJ Bromley Kent | British | 1403010005 | ||||||
MACDONALD, Iain Graham Ross | Secrétaire | 172 White Hill HP5 1AZ Chesham Buckinghamshire | British | Solicitor | 66669510002 | |||||
NOEL, Dawn | Secrétaire | 6 Cantley Road Hanwell W7 2BQ London | British | 79021070001 | ||||||
TAYLOR, Robert Mark | Secrétaire | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | 43039830001 | ||||||
WHALLEY, Amanda | Secrétaire | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||
RB SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire désigné | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006270001 | |||||||
CARRAGHER, Madeleine | Administrateur | 17 Stadium Street Chelsea SW10 0PU London | British | Chartered Surveyor | 46150230001 | |||||
COMPTON, Colin Richard | Administrateur | Kingsland House Kingsland Lane Leavenheath CO6 4PD Colchester Essex | British | Chartered Surveyor | 12075710001 | |||||
LARGE, Martin Gerald | Administrateur | Legh Manor Farmhouse Cuckfield Road Ansty RH17 5AJ Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 44118740002 | ||||
MARPLES, James Patrick | Administrateur | Churchfield All Saints Lane Sutton Courtenay OX14 4AG Abingdon Oxfordshire | British | Chartered Surveyor | 80588240002 | |||||
PLATT, Harry | Administrateur | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Chester House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 41914500003 | ||||
RUSHTON, Christopher Arthur | Administrateur | Copper Beaches Plaw Hatch Lane, Sharpthorne RH19 4JL East Grinstead West Sussex | England | British | Surveyor | 44369580002 | ||||
TAYLOR, Robert Mark | Administrateur | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 43039830001 | |||||
RB DIRECTORS ONE LIMITED | Administrateur désigné | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WORKSPACE 9 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Workspace 2 Limited | 06 avr. 2016 | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Chester House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
WORKSPACE 9 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 02 avr. 2002 Livré le 09 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage kingsmill business park, chapel mill road, kingston upon thames, surrey l/h t/n SGL633096. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of agreement for lease | Créé le 25 sept. 2001 Livré le 12 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee | |
Brèves mentions The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement of the lease dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of development agreement | Créé le 25 sept. 2001 Livré le 12 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee | |
Brèves mentions The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge absolutely all that the agreement dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 sept. 2001 Livré le 12 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Including the company's rights in an agreement dated 02 february 2001 for the grant of a 999 year lease of land of villiers road, kingston-upon-thames, surrey... Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0