WORKSPACE 9 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWORKSPACE 9 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04106607
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WORKSPACE 9 LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe WORKSPACE 9 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Canterbury Court Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WORKSPACE 9 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLE PROPERTY DEVELOPMENTS (KINGSTON) LIMITED15 déc. 200015 déc. 2000
    RBCO 348 LIMITED13 nov. 200013 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de WORKSPACE 9 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WORKSPACE 9 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE à Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE le 01 nov. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 25 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 oct. 2015

    État du capital au 05 oct. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2014

    État du capital au 07 oct. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 oct. 2013

    État du capital au 14 oct. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    4 pagesAA

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Jameson Paul Hopkins en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Harry Platt en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* le 04 août 2011

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Harry Platt le 19 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Colin Clemett le 19 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graham Colin Clement le 24 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de WORKSPACE 9 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARFORA, Carmelina
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Secrétaire
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    150287080001
    CLEMETT, Graham Colin
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Administrateur
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritishDirector123744930001
    HOPKINS, Jameson Paul
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Administrateur
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritishDirector79842180002
    BINNS, Adam
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    BritishAccountant113638490001
    CHAPMAN, Paul Stephen
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    Secrétaire
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    British1403010005
    MACDONALD, Iain Graham Ross
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor66669510002
    NOEL, Dawn
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    Secrétaire
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    British79021070001
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Secrétaire
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    RB SECRETARIAT LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Secrétaire désigné
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006270001
    CARRAGHER, Madeleine
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    Administrateur
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    BritishChartered Surveyor46150230001
    COMPTON, Colin Richard
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    Administrateur
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    BritishChartered Surveyor12075710001
    LARGE, Martin Gerald
    Legh Manor Farmhouse Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Legh Manor Farmhouse Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Surveyor44118740002
    MARPLES, James Patrick
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    BritishChartered Surveyor80588240002
    PLATT, Harry
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    Administrateur
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector41914500003
    RUSHTON, Christopher Arthur
    Copper Beaches
    Plaw Hatch Lane, Sharpthorne
    RH19 4JL East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Copper Beaches
    Plaw Hatch Lane, Sharpthorne
    RH19 4JL East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritishSurveyor44369580002
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant43039830001
    RB DIRECTORS ONE LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Administrateur désigné
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WORKSPACE 9 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Workspace 2 Limited
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    England
    06 avr. 2016
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleEngland And Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WORKSPACE 9 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 02 avr. 2002
    Livré le 09 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage kingsmill business park, chapel mill road, kingston upon thames, surrey l/h t/n SGL633096. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of agreement for lease
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 12 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee
    Brèves mentions
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement of the lease dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of development agreement
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 12 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee
    Brèves mentions
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge absolutely all that the agreement dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 12 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including the company's rights in an agreement dated 02 february 2001 for the grant of a 999 year lease of land of villiers road, kingston-upon-thames, surrey... Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0