WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD

WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04106739
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    • (4525) /

    Où se situe WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    Adresse du siège social
    Oury Clark Herschel House
    58 Herschel Street
    SL1 1HD Slough
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CALISMORE HOMES LIMITED08 nov. 200008 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2006

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 02 avr. 2012

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 janv. 2012

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 juil. 2011

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 janv. 2011

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 juil. 2010

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 janv. 2010

    2 pages3.6

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Changement d'adresse du siège social de * Oury Clark Herschel House 58 Herschel Street Slough Berkshire SL1 1HD* le 15 oct. 2009

    1 pagesAD01

    legacy

    1 pages287

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 08 juil. 2009

    2 pages3.6

    legacy

    2 pages405(1)

    legacy

    6 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    9 pages395

    legacy

    7 pages395

    Certificat de changement de nom

    Company name changed calismore homes LIMITED\certificate issued on 11/07/07
    3 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    5 pages395

    legacy

    5 pages395

    legacy

    5 pages395

    Qui sont les dirigeants de WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Ruth Lloyd
    Halford Hill
    Llanberis
    LL55 4EN Caernarvon
    Gwynedd
    Secrétaire
    Halford Hill
    Llanberis
    LL55 4EN Caernarvon
    Gwynedd
    British41290070003
    WILLIAMS, Hugh Stanley
    Halford Hill
    High Street
    LL55 4EN Llanberis
    Gwynedd
    Administrateur
    Halford Hill
    High Street
    LL55 4EN Llanberis
    Gwynedd
    BritishCompany Director73216080001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secrétaire
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British80241770001
    TESTER, William
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ Holloway
    London
    Administrateur
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ Holloway
    London
    BritishCompany Registration Agent72822770001

    WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third party debenture
    Créé le 23 août 2007
    Livré le 05 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from williams homes (wales) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of property charge please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pricapita Limited
    Transactions
    • 05 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Third party legal charge
    Créé le 23 août 2007
    Livré le 05 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from williams homes (wales) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at caeau gleision rhiwlas bangor t/no WA618327 all plant machinery and equipment and the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pricipita Limited
    Transactions
    • 05 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2008Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 128 mai 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
    • 125 avr. 2012Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 15 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the northwest of penmaenmawr road, llanfairfechan north wales t/no CYM215297 together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • UK Country Capital Limited
    Transactions
    • 15 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 15 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land to the north west of penmaenmawr road, llanfairechan, north wales t/no CYM221275. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • UK Country Capital Limited
    Transactions
    • 15 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 15 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the north west of penmaenmawr road, llanfairfechan, north wales t/no CYM236790 together with all buildings, fixtures and fixed plant and machinery and all guarantees, indemnities, rent deposits, agreements, contracts, undertakings and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • UK Country Capital Limited
    Transactions
    • 15 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 15 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the north west of penmaenmawr road, llanfairfechan, north wales t/no WA910961 together with all buildings, fixtures and fixed plant and machinery and all guarantees, indemnities, rent deposits, agreements, contracts, undertakings and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • UK Country Capital Limited
    Transactions
    • 15 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 07 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H /l/h property k/a land to the rear of tai bodawen rhostryfan caernarfon gwynedd t/no cym 93160 together with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, by way of fixed charge any shares and the benefit of all guarantees, indemnities, rent deposits, agreements, contracts and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • UK Country Capital Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 15 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a land on the north side of penmaenmawr road llanfairfechan conwy t/no CYM221275, f/h land k/a land at caeau gleison castell farm rhiwlas bangor gwynedd t/no WA618327 by way of fixed charge the goodwill by way of floating a mortgage all moveable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Valley Confirming Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 mars 2006
    Livré le 09 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land at the rear of tai bodawen rhostryfan caernafon gwynedd t/n CYM93160. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the north west side of penmaenmawr road llamfairfechan conwy t/no's CYM221275,CYM215297 and CYM236790 and the f/h land k/a caeau gleision castell far rhiwlas gwynedd t/no WA618327,any f/h and l/h property and its proceeds of sale,all rental income,all the plant and machinery and fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as land at the rear of tai bodawen rhostryfan caernarfon gwynedd, t/n CYM93160. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property known as land on the north east side of penmaenmawr road llanffairfechan t/n WA910961,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land lying to the north east side of pennaenmawr road llanfaircechan WA910961 and land to the rear of tai bodawen rhostryfan caernarfon t/n CYM93160. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 oct. 2004
    Livré le 13 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 mai 2003
    Livré le 03 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £175,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land at rear of ta bodawen rhostryfan t/n CYM93160, land at caeu gleision castell farm rhiwlas t/n WA618327, land to the north east of penmaenmawr road llanfairfechan t/n WA910961.
    Personnes ayant droit
    • Mortgage Guarantee Limited
    Transactions
    • 03 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2002
    Livré le 22 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that land and buildings situate at and k/a (1) land lying to the north east of penmaenmawr road, llanfairfechan (2) land adjoing bangor railway institute, bangor, gwynedd with f/h absolute under t/nos. WA910961 and SWM26282 (3) unregistered land and buildings situate and k/a land to the rear of tai bodawen terrace, rhostryfan and (4) unregistered land adjoining the south west side of frondeg estate road at rhostryfan. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transactions
    • 22 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 oct. 2001
    Livré le 01 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land on the south east side of tai glanffynnon llanrug gwynedd t/n WA618331.
    Personnes ayant droit
    • Calismore Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 oct. 2001
    Livré le 01 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,500 and all other monies due or to to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land at caeau gleision, castell farm, rhiwlas, gwynedd t/n WA618327.
    Personnes ayant droit
    • Calismore Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 oct. 2001
    Livré le 01 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land lying to the north east side of penmaenmawr road llanfairfechan gwynedd t/n WA910961.
    Personnes ayant droit
    • Calismore Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WILLIAMS COMMERCIAL (WALES) LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Graham Clark
    Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    receiver manager
    Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Robert Edward Caunce Cook
    Hacker Young And Ptnrs
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    receiver manager
    Hacker Young And Ptnrs
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    2
    DateType
    16 juin 2015Conclusion of winding up
    20 nov. 2008Petition date
    25 févr. 2009Commencement of winding up
    25 sept. 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Elliot H Green
    Herschel House, 58 Herschel Street
    SL1 1PG Slough
    Berkshire
    practitioner
    Herschel House, 58 Herschel Street
    SL1 1PG Slough
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0