HALLCO 1021 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHALLCO 1021 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04111742
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HALLCO 1021 LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe HALLCO 1021 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Eversley
    Gawsworth Road
    SK11 8UG Macclesfield
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HALLCO 1021 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROLAND BARDSLEY HOMES LIMITED13 févr. 200113 févr. 2001
    HALLCO 534 LIMITED21 nov. 200021 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de HALLCO 1021 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour HALLCO 1021 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2017 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2016 avec mises à jour

    24 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    20 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 déc. 2015

    État du capital au 30 déc. 2015

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de , 147 Broken Cross, Macclesfield, Cheshire, SK11 8TU à Eversley Gawsworth Road Macclesfield Cheshire SK11 8UG le 08 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 oct. 2014

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 nov. 2014

    État du capital au 10 nov. 2014

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2013

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2013

    État du capital au 02 déc. 2013

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 nov. 2012

    14 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Claire Bardsley en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de , Globe Square, Dukinfield, Cheshire, SK16 4RG le 09 oct. 2012

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Roland Bardsley en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HALLCO 1021 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALCOCK, John
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    Secrétaire
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    British171499700001
    ALCOCK, John Herbert
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    EnglandBritish45302690001
    BARDSLEY, Anne
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    EnglandBritish171499490002
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    British107908930001
    SHERRATT, Juanita Sandra
    66 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Greater Manchester
    Secrétaire
    66 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Greater Manchester
    British75816200001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    ADAMS, Brian Kenneth
    16 Meadowbank Gardens
    WA3 5LX Glazebury
    Cheshire
    Administrateur
    16 Meadowbank Gardens
    WA3 5LX Glazebury
    Cheshire
    British95853080001
    ASHWORTH, David James
    3 Hollybank Rise
    SK16 5EG Dukinfield
    Cheshire
    Administrateur
    3 Hollybank Rise
    SK16 5EG Dukinfield
    Cheshire
    British75816270001
    BARDSLEY, Anne
    Cranbrook
    Oak Road Mottram
    SK10 4RA St Andrews
    Cheshire
    Administrateur
    Cranbrook
    Oak Road Mottram
    SK10 4RA St Andrews
    Cheshire
    EnglandBritish38204280002
    BARDSLEY, Claire Kelly
    Globe Lane
    SK16 4RG Dukinfield
    Globe Square
    Cheshire
    Administrateur
    Globe Lane
    SK16 4RG Dukinfield
    Globe Square
    Cheshire
    EnglandBritish141029570001
    BARDSLEY, Roland
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    Administrateur
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    United KingdomBritish140518810002
    BARDSLEY, Roland
    Hill House Farm Singleton Road
    Weeton
    PR4 3JJ Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Hill House Farm Singleton Road
    Weeton
    PR4 3JJ Preston
    Lancashire
    British38204410001
    BARDSLEY, Sharon Anne
    Croft Cottage
    40 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Croft Cottage
    40 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British113005600001
    BARDSLEY, Wayne Roland
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    Administrateur
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    EnglandBritish125231330001
    HARPER, Paul
    4 Freshfield Road
    Heaton Mersey
    SK4 3HN Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    4 Freshfield Road
    Heaton Mersey
    SK4 3HN Stockport
    Cheshire
    British7152980001
    HOULIHAN, Colin Anthony
    Ednaston Grange
    Hollington Lane Ednaston
    DE6 3AE Brailsford Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Ednaston Grange
    Hollington Lane Ednaston
    DE6 3AE Brailsford Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish149560460001
    MACDOUGAL, Neil Charles
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish93401120003
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish107908930001
    MEARS, Helena Llewelyn
    September House
    38 Kingsley Road, Cottam
    PR4 0LT Preston
    Lancashire
    Administrateur
    September House
    38 Kingsley Road, Cottam
    PR4 0LT Preston
    Lancashire
    British121960240001
    PINDER, Ronald
    Fir Tree Cottage
    Lily Lanes
    OL6 9AD Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Administrateur
    Fir Tree Cottage
    Lily Lanes
    OL6 9AD Ashton Under Lyne
    Lancashire
    British75816520001
    SPENCER, Keith
    2 The Paddock
    Greenfield
    OL3 7PU Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    2 The Paddock
    Greenfield
    OL3 7PU Oldham
    Lancashire
    British2715230001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HALLCO 1021 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gawsworth Road
    SK11 8UG Macclesfield
    Eversley
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gawsworth Road
    SK11 8UG Macclesfield
    Eversley
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04111742
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HALLCO 1021 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 2004
    Livré le 10 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south east side of ashworth street, bury, greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 2004
    Livré le 24 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at new street/lord street eccleston chorley lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 08 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage chelford house offerton road offerton stockport t/no GM521542. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at high barn road royton greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2003
    Livré le 30 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at compstall road romiley greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 08 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage tahiti mill queens road ashton under lyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2003
    Livré le 21 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at crompton way bolton. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 2003
    Livré le 22 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Cape mill shaw oldham t/n GM431352 (part) and GM426463 (part). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2003
    Livré le 15 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a lodge mill ramsbottom described in a transfer dated 24/09/02 t/n LA873335 part and t/n LA775639 part. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a the almonds hotel church lane marple t/n GM730810. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land at church road tarleton 87 church road and 5 gorse lane tarleton t/n LA885373 LA709879 and LA709919. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a land on the east side of burnside hadfield glossop t/n DY340451. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the property k/a land and dwelling house "the gerrards" stockport road hyde. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 4 hough lane wilmslow t/no CH120763. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a plots of land at springwood way limehurst ashton under lyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 oct. 2001
    Livré le 13 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land at glenside drive woodley stockport greater manchester t/n GM177011. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 oct. 2001
    Livré le 12 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 65 to 81 st petersgate stockport greater manchester t/no: GM216877. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 26 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a stamford commercial mill claremont street hurst and part of land and buildings on the north side of crompton street ashton under lyne. T/nos LA144641 and part of GM757009. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 avr. 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a firstly land at 6 london road south poynton cheshire and secondly land adjoining t/n CH7328. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 04 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land at rankbottom hadfield - DY209035. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 mars 2001
    Livré le 26 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in any f/h or l/h property being part exchange properties for the time being belonging to or charged to the company other than the property hereinafter described.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 déc. 2000
    Acquis le 02 mars 2001
    Livré le 20 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All f/h and l/h property adjacent to hope street ramsbottom GM541578. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2001Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 oct. 2000
    Acquis le 02 mars 2001
    Livré le 20 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land at clifton drive south lytham st annes lancashire LA783314. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2001Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 oct. 2000
    Acquis le 02 mars 2001
    Livré le 20 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H the ferns underwood road alderley edge cheshire CH265360 and CH168616. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2001Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 16 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0