BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED

BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04113691
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BETT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED22 nov. 200422 nov. 2004
    KEEPCYCLE LIMITED24 nov. 200024 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giles Henry Sharp le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Edward Lewis le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 22 oct. 2015

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 30 High Street Westerham Kent England and Wales TN16 1RG à Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP le 23 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jon William Mortimore en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Giles Sharp en tant qu'administrateur le 23 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 15 déc. 2014

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 nov. 2014

    État du capital au 24 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 24 nov. 2013

    18 pagesRP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 nov. 2013

    État du capital au 25 nov. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    06 déc. 2013A second filed AR01 was registered on 06/12/2013

    Cessation de la nomination de Elizabeth Catchpole en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Jon William Mortimore en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Fitzsimmons le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secrétaire
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808310001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Administrateur
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Administrateur
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    GANDHI, Devendra
    50 Warlington Road
    CR7 7DE Thornton Heath
    Surrey
    Secrétaire
    50 Warlington Road
    CR7 7DE Thornton Heath
    Surrey
    British75350600001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British72249480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Administrateur
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritishDirector91412650001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director62279790001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary78691990001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishAccountant75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MCNEIL, Phillip
    14 Lock House Lane
    Earswick
    YO32 9FT York
    North Yorkshire
    Administrateur
    14 Lock House Lane
    Earswick
    YO32 9FT York
    North Yorkshire
    BritishManaging Director103066930001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    30
    England And Wales
    Administrateur
    High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    30
    England And Wales
    United KingdomBritishCfo207729000002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 09 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2007
    Livré le 21 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transactions
    • 21 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0