PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED

PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04113906
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MABLAW 421 LIMITED24 nov. 200024 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    GAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 déc. 2013

    État du capital au 19 déc. 2013

    • Capital: GBP 651,818.18
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* le 25 mars 2013

    2 pagesAD01

    Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012

    3 pagesCH01

    Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kerry Jane Crompton le 16 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* le 14 mai 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952730001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SORRELL, Barbara Ann
    30 High Street
    Bovingdon
    HP3 0HG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    30 High Street
    Bovingdon
    HP3 0HG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British55772910002
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    ANDREWS, Simon
    The Cedars
    Graemesdyke Road
    HP4 3LX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Cedars
    Graemesdyke Road
    HP4 3LX Berkhamsted
    Hertfordshire
    British74990110002
    COTTON, David Simon
    The Orchards 85 Peddars Lane
    Stanbridge
    LU7 9JD Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Orchards 85 Peddars Lane
    Stanbridge
    LU7 9JD Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British58038680002
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    DIXON, Jill Margaret
    47 Merry Hill Mount
    WD23 1DJ Bushey
    Hertfordshire
    Administrateur
    47 Merry Hill Mount
    WD23 1DJ Bushey
    Hertfordshire
    British59005140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    JACKSON, Michael Edward Wilson
    Harcombe House
    Park Lane Ropley
    SO24 0BE Alresford
    Hampshire
    Administrateur
    Harcombe House
    Park Lane Ropley
    SO24 0BE Alresford
    Hampshire
    British40521530003
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PINNING, Stephen Peter
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    Administrateur
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    British14848160001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Administrateur
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330002
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    MABLAW NOMINEES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303350001

    PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 oct. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 03 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Elderstreet Capital Partners Nominees Limited
    Transactions
    • 03 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juin 2002
    Livré le 02 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PINNACLE COMPUTER SYSTEMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2014Commencement of winding up
    05 nov. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0