FINNING ACQUISITION CO.
Vue d'ensemble
Nom de la société | FINNING ACQUISITION CO. |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | 04114427 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FINNING ACQUISITION CO. ?
Adresse du si ège social | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FINNING ACQUISITION CO. ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour FINNING ACQUISITION CO. ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Francis Neil Primrose en tant qu'administrateur le 31 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Parkes en tant que directeur le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017 | 11 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Stephen Hogg en tant qu'administrateur le 15 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Stephen Hogg en tant que secrétaire le 15 déc. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gregory Paul Palaschuk en tant que directeur le 15 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gregory Paul Palaschuk en tant que secrétaire le 15 déc. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Gregory Paul Palaschuk en tant que secrétaire le 31 août 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Gregory Paul Palaschuk en tant qu'administrateur le 31 août 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Thomas en tant que directeur le 31 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Thomas en tant que secrétaire le 31 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin Parkes en tant qu'administrateur le 31 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Robert Dickinson en tant que directeur le 31 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FINNING ACQUISITION CO. ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGG, Mark Stephen | Secrétaire | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire | 241340710001 | |||||||
HOGG, Mark Stephen | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire | England | British | Finance Director | 221576730001 | ||||
PRIMROSE, David Francis Neil | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire | England | Canadian | Managing Director | 254318780001 | ||||
NETHERWAY, Robert William | Secrétaire | Hewden Stuart Plc, Trafford House Chester Road, Stretford M32 0RL Manchester | British | Finance Director | 30995760008 | |||||
PALASCHUK, Gregory Paul | Secrétaire | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire | 214287450001 | |||||||
SPROUT, Douglas | Secrétaire | Watling Street WS11 8LL Cannock Finning (Uk) Ltd Staffordshire England | British | 149541780001 | ||||||
THOMAS, Christopher | Secrétaire | Watling Street WS11 8LL Cannock Fining (Uk) Ltd Staffordshire Uk | British | 151778890001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
CARTHY, Jack | Administrateur | 16 Little Aston Hall Aldridge Road, Little Aston B74 3BH Sutton Coldfield West Midlands | Canadian | Managing Director | 66393410001 | |||||
DAVIES, Michael | Administrateur | Watling Street WS11 8LL Cannock Finning (Uk) Ltd Staffordshire | United Kingdom | British | Company Ditrector | 140297230001 | ||||
DICKINSON, Neil Robert | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd. Watling Street WS11 8LL Cannock Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 102224030002 | ||||
FRASER, Andrew | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 8LL Cannock Staffordshire | United Kingdom | Canadian | Company Director | 117518070002 | ||||
HOTCHKISS, Colin Archibald | Administrateur | Watling Street WS11 8LL Cannock C/O Finning (Uk) Ltd Staffordshire | Canadian | Company Director | 133634850001 | |||||
JARVIS, Paul James Christopher | Administrateur | 49 Oatlands Avenue KT13 9SS Weybridge Surrey | England | British | Engineer | 2293800001 | ||||
LLOYD, Nicholas Bradley | Administrateur | Hewden, Trafford House Chester Road, Stretford M32 0RL Manchester | British | Managing Director | 91982390004 | |||||
NETHERWAY, Robert William | Administrateur | Hewden Stuart Plc, Trafford House Chester Road, Stretford M32 0RL Manchester | United Kingdom | British | Finance Director | 30995760008 | ||||
PALASCHUK, Gregory Paul | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire | England | Canadian | Director And Company Secretary | 204853080001 | ||||
PARKES, Kevin | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 3LL Cannock Staffordshire | England | British | Director | 197352210001 | ||||
SHERLOCK, Brian Foster | Administrateur | Hewden Stuart Plc, Trafford House Chester Road, Stretford M32 0RL Manchester | British | Director | 107903020002 | |||||
SPROUT, Douglas | Administrateur | C/O Finning (Uk) Ltd Watling Street WS11 8LL Cannock Staffordshire | United Kingdom | Canadian | Company Director | 149547490001 | ||||
THOMAS, Christopher | Administrateur | Watling Street WS11 8LL Cannock Fining (Uk) Ltd Staffordshire Uk | United Kingdom | British | Finance Director | 149555200001 | ||||
WAITES, Michael | Administrateur | Suite 2002, 1221 W. Cordova St V6C 3R5 Vancouver British Columbia Canada | Canada | Canadian | Cfo | 121730630001 | ||||
WHITEHEAD, Douglas William Geoffrey | Administrateur | 435 Southborough Drive FOREIGN West Vancouver B.C. V7s 1m3 Canada | Canadian | President And Ceo | 73575490002 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FINNING ACQUISITION CO. ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finning (Uk) Ltd. | 30 juin 2016 | Watling Street WS11 8LL Cannock Finning (Uk) Ltd. England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
FINNING ACQUISITION CO. a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Créé le 07 févr. 2001 Livré le 14 févr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the guarantee and the other subone loan documents | |
Brèves mentions To pledge and charge the whole rights title interest and benefit in and to the existing shares and other securities.any securities to which it becomes entitles after the charge date in favour of the lender. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge over shares | Créé le 07 févr. 2001 Livré le 13 févr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the guarantee and the other subone loan documents to which it is a party, or its affairs under the subone credit agreement (all as defined therein) | |
Brèves mentions All interest in the collateral (as defined therein) together with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0