ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED

ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04119462
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOREX HEALTH (GERMANY) LIMITED30 nov. 200030 nov. 2000

    Quels sont les derniers comptes de ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2013 au 30 sept. 2013

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 déc. 2013

    État du capital au 20 déc. 2013

    • Capital: EUR 3
    SH01

    Cessation de la nomination de Andrew James Edward Thomson en tant que directeur le 30 août 2013

    2 pagesTM01

    État du capital au 24 juin 2013

    • Capital: EUR 3
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Allot shares & company business 29/03/2013
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 29 mars 2013

    • Capital: GBP 2
    • Capital: EUR 37,118,217
    4 pagesSH01

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    14 pagesAA

    Nomination de David William Hart Gray en tant que secrétaire le 31 mars 2013

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gareth Antony Wilson en tant que secrétaire le 31 mars 2013

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Adrian Charles Stevens en tant que directeur le 30 juin 2012

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    16 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2012 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Isoft Group Plc 300 Longbarn Boulevard Woolston Cheshire WA2 0XD

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrea Fiumicelli le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew James Edward Thomson le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Charles Stevens le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gareth Antony Wilson le 12 sept. 2011

    2 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357840001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Secrétaire
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162048040001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Administrateur
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Administrateur
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    HOGARTY, Martin John
    Littleham
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Littleham
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector61700350001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector178097680001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector34428100003
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishFinance Director57516220003
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Administrateur
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Administrateur
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ISOFT HEALTH (GERMANY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A german law governed confirmation and junior ranking interest pledge agreement
    Créé le 07 déc. 2010
    Livré le 16 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The interests in the company together with all ancillary rights and claims associated with the interests see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Interest pledge agreement
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 15 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the finance parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledgor is the sole limited partner of the company and holds a limited partner's capital contribution in the company in the aggregate nominal amount of eur 50.000. the existing interests are fully paid up. There is no obligation for the pledgor to make additional contributions. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 13 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An interest pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 29 oct. 2008
    Livré le 13 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Each of the pledgers under the interest pledge agreement pledges the interests to each of the pledgees and to each future pledgee for their rateable and equally ranking interest as security see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V.,London Branch (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An interest pledge and release agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 29 juil. 2008
    Livré le 15 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the finance parties from the obligors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Existing interests and the future interests see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V (The Security Agent) and Aep Financial Services Holdings Pty Limited (the Original Term Equity Bridge Lender)
    Transactions
    • 15 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of accession
    Créé le 27 nov. 2007
    Livré le 13 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transactions
    • 13 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Interest pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 27 nov. 2007
    Livré le 13 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The existing interests and the future interests,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch (Security Agent)
    Transactions
    • 13 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 24 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Créé le 13 avr. 2006
    Livré le 28 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 01 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any other of the parent company's subsidiaries (together the group) to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property known as unit 2 firecrest court warrington t/no CH445922, l/h property known as upminster unit 16 essex, l/h property known as sarum gate basingstoke t/no HP208786. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts and other debts. Floating charge all undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee)
    Transactions
    • 01 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A legal charge containing fixed and floating charges
    Créé le 21 juil. 2003
    Livré le 06 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the f/h property known as churchfields, stonesfield, witney OX8 8PQ t/no ON214941 and all that f/h property known as unit 2 (postal number 310) firecrest court, centre park, warrington, cheshire, t/no CH445922. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Securedparties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second fixed and floating security document (the "second security document") dated 6TH september 2001 between the company,certain other chargors as listed in the second security document (together the "chargors") and lloyds tsb bank capital markets in it's capacity as security trustee for the secured parties
    Créé le 06 sept. 2001
    Livré le 18 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due by any chargor to any secured party under or in connection with any secured document including under the amended and restated facility agreement
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC, Capital Markets
    Transactions
    • 18 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document between the company, certain other chargors as listed in the security document (together the chargors) and lloyds tsb bank PLC, capital markets in its capacity as security trustee for the secured parties (as defined)
    Créé le 28 déc. 2000
    Livré le 03 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any chargor to any secured party under or in connection with any secured document (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC, Capital Markets
    Transactions
    • 03 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement over partnership interests
    Créé le 20 déc. 2000
    Livré le 04 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the interest pledge agreement and the facility agreement defined therein
    Brèves mentions
    A). all the partnership interest in and to torex gmbh & co kg (the "partnership") b). The "partnership interests" c). All present and future rights to receive distributions payable on the partnership interests and all related credit balances liquidation proceeds any compensation in case of a termination and/or withdrawal of a partner of the partnership and all other pecunary claims associated with the partnership interests as well as any other substitutes received by the company in the partnership interests (all the above being the "pledged interests". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0