PINCO 1555 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPINCO 1555 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04125064
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PINCO 1555 LIMITED ?

    • (5020) /
    • (5030) /

    Où se situe PINCO 1555 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    GRANT THORNTON UK LLP
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PINCO 1555 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour PINCO 1555 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    4 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 sept. 2010

    12 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    8 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 28 mars 2009

    8 pages2.24B

    Certificat modifié de constitution du comité des créanciers

    1 pages2.26B

    Résultat de la réunion des créanciers

    68 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    64 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.15B/2.14B

    15 pages2.16B

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    26 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    27 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de PINCO 1555 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANTHONY, Adrian John
    Ashcroft 24 Four Ashes Road
    Bentley Heath
    B93 8LX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Ashcroft 24 Four Ashes Road
    Bentley Heath
    B93 8LX Solihull
    West Midlands
    BritishDirector79039640001
    HARRIS, Anthony Vernum
    34 Ridgeway Moor
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    34 Ridgeway Moor
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector74224000001
    WILLIAMS, Kelvin
    7 Park Road
    RH8 0AL Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    7 Park Road
    RH8 0AL Oxted
    Surrey
    BritishInterim Management79672690001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BEASLEY, Colin Frank
    Bleak House Farm
    75 Kilburn Lane
    DE56 0SF Openwood Gate Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    Bleak House Farm
    75 Kilburn Lane
    DE56 0SF Openwood Gate Belper
    Derbyshire
    BritishDirector74224130001
    CONLIN, Joseph
    1, Wattles Lane
    Acton Trussell
    ST17 ORE Stafford
    Inshallah
    Staffordshire
    Administrateur
    1, Wattles Lane
    Acton Trussell
    ST17 ORE Stafford
    Inshallah
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector140315130001
    DARKE, Shaun
    Lamorna
    9 Forest Hill Park
    S81 0NZ Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Lamorna
    9 Forest Hill Park
    S81 0NZ Worksop
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector15123380002
    EVANS, Ralph Anthony
    Grace House 90 Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6JU York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Grace House 90 Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6JU York
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector48052490002
    HARRIS, Anthony Vernum
    34 Ridgeway Moor
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    34 Ridgeway Moor
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector74224000001
    JENNINGS, Howard
    19 Dulwich Village
    Dulwich
    SE21 7BT London
    Administrateur
    19 Dulwich Village
    Dulwich
    SE21 7BT London
    BritishDirector76073520001
    LUCAS, Paul William
    Wootton Grange
    Wootton Green Lane
    CV7 7BQ Balsall Common
    Administrateur
    Wootton Grange
    Wootton Green Lane
    CV7 7BQ Balsall Common
    EnglandBritishCo Director77754260001
    MACPHERSON, Arnold Duncan
    2 Fintry Road
    AB1 8HL Craigiebuckler
    Aberdeen
    Administrateur
    2 Fintry Road
    AB1 8HL Craigiebuckler
    Aberdeen
    BritishOperations Director93141600001
    MORGAN, Richard
    5 River Court
    Ladies Spring Grove
    S17 3LR Sheffield
    Yorkshire
    Administrateur
    5 River Court
    Ladies Spring Grove
    S17 3LR Sheffield
    Yorkshire
    BritishDirector76073560001
    OWEN, Mark Philip
    25 Oakfield Road
    AL5 2NW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    25 Oakfield Road
    AL5 2NW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandEnglishDirector43568980001
    PARKINSON, Stuart Garry
    3 Granby Close
    PR9 9QG Southport
    Merseyside
    Administrateur
    3 Granby Close
    PR9 9QG Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishOperations Manager115899500001
    WILLIAMS, Kelvin
    7 Park Road
    RH8 0AL Oxted
    Surrey
    Administrateur
    7 Park Road
    RH8 0AL Oxted
    Surrey
    EnglandBritishInterim Management79672690001
    YATES, Adrian
    Letwell Court
    DN4 6GA Doncaster
    3
    South Yorkshire
    Administrateur
    Letwell Court
    DN4 6GA Doncaster
    3
    South Yorkshire
    United KingdomBritishFinanace Director128845000002
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    PINCO 1555 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 december 2005 and
    Créé le 17 nov. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a 172 western road kilmarnock t/no AYR8979.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 december 2005 and
    Créé le 17 nov. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole those subjects k/a 74 annan road dumfries t/no DMF2068.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 30 sept. 2005
    Livré le 11 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 sept. 2003
    Livré le 26 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    £5,862.51 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The rents or other money. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transactions
    • 26 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 27 janv. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    £14,687.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Unit 8 victoria road trading estate portslade east sussex.
    Personnes ayant droit
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    74 annan road dumfries.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One forth avenue kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    21 peebles street ayr.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    21 and 21 1/2 high street turriff.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 main street bainsford falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 commercial road hawick.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    172 western road kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7TH december 2001
    Créé le 15 nov. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25/27 new row perth.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 mai 2001
    Livré le 31 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 11 mai 2001
    Livré le 17 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 17 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PINCO 1555 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 sept. 2009Administration ended
    29 sept. 2008Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Keith Hinds
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Neil Tombs
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    2
    DateType
    15 mars 2011Dissolved on
    21 sept. 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Keith Hinds
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Neil Tombs
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0