TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED

TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04126418
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    • Assurance-vie (65110) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Evelyn Partners Llp
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TILNEY GROUP LIMITED12 déc. 201612 déc. 2016
    YORKSHIRE INVESTMENT GROUP LIMITED15 déc. 200015 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 sept. 2022

    13 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY à C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG le 05 juil. 2022

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gavin Raymond White le 14 juin 2022

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Martin Baddeley le 14 juin 2022

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL United Kingdom à C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY le 01 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 sept. 2021

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Deborah Ann Saunders en tant que secrétaire le 01 sept. 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Gavin Raymond White en tant que secrétaire le 01 sept. 2021

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Nicola Claire Mitford-Slade en tant que directeur le 18 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Woodhouse en tant que directeur le 18 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Nicola Claire Mitford-Slade en tant qu'administrateur le 22 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Donald William Sherret Reid en tant que directeur le 22 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rehana Hasan en tant que secrétaire le 22 oct. 2020

    1 pagesTM02

    Nomination de Deborah Ann Saunders en tant que secrétaire le 22 oct. 2020

    2 pagesAP03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England à 25 Moorgate London EC2R 6AY

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Modification des détails de Uk Wealth Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITE, Gavin Raymond
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    287111660001
    BADDELEY, Andrew Martin
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish82469460001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Secrétaire
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    173987280001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    197499510001
    HASAN, Rehana
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Secrétaire
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    217675490001
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Secrétaire
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    British157133400001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Secrétaire
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    SAUNDERS, Deborah Ann
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    Secrétaire
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    276008310001
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    BUSSEY, Michael Adrian
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    United KingdomBritish52554700003
    CHAPMAN, Andrew
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish39777190002
    COLEMAN, Lynn Rose
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    United KingdomBritish149721950001
    CRESWELL-TURNER, Miles Marius
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    EnglandBritish160087860001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    DOWNING, Wadham St. John
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish203301710001
    DUFTON, Jeremy Jon
    1 Long Meadow
    High Ackworth
    WF7 7EA Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Long Meadow
    High Ackworth
    WF7 7EA Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish56706650001
    FLETCHER, Alfred Olding
    154a Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Pontelant
    Northumberland
    Administrateur
    154a Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Pontelant
    Northumberland
    EnglandBritish226590003
    FRASER, Thomas Aird
    Flat 3 20 Lower Sloane Street
    SW1W 8BJ London
    Administrateur
    Flat 3 20 Lower Sloane Street
    SW1W 8BJ London
    Australian74112910002
    HAINSWORTH BREAR, Timothy Austin
    Wyndorf 11a Fairway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JT Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wyndorf 11a Fairway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish110677380001
    HALL, Peter Lindop
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish212005290001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish26428410003
    HOGG, Andrew
    6 Tranfield Gardens
    Guiseley
    LS20 8PZ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Tranfield Gardens
    Guiseley
    LS20 8PZ Leeds
    West Yorkshire
    British63356910003
    JOHNSTON, Carol Ann
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    Administrateur
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    British52538020002
    JONES, Peter Francis
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33965180002
    MITFORD-SLADE, Nicola Claire
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    Administrateur
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    United KingdomBritish276051890001
    MULLORD, Kathleen Francis
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    United KingdomSouth African160087800001
    POLIN, Jonathan Charles
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    ScotlandBritish97840060003
    PORTEOUS, John Robert
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish166212270001
    REID, Donald William Sherret
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    EnglandBritish212004930001
    SAWYER, Gareth Matthew
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    Administrateur
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    United KingdomBritish46468670003
    SINCLAIR, Richard Harris
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    EnglandBritish204668540001
    TAGLIABUE, Alfio
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomItalian76352220004
    WOODHOUSE, Christopher
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    Administrateur
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    EnglandBritish238888480001
    WRIGHT, Paul Vernon
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish137936580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4438652
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 11 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 22 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no RNF00072345A for £200,000 over life of phillip gordon bradshaw with all sums,bonuses and benefits thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 22 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no RNF0072346A for £200,000 over life of hugh heron with all bonuses and benefits thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 22 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no RNF0072342A for £200,000 over life of andrew hogg with all sums,bonuses and benefits thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 22 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no RNF0072344A for £200,000 over life of peter francis jones with all sums,bonuses and benefits thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 oct. 2002
    Livré le 17 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Licence to assign
    Créé le 27 nov. 2001
    Livré le 28 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and media works corporation communications LTD to the chargee pursuant to the licence to assign
    Brèves mentions
    The sum of £10,350.00 plus vat the account in which the sum is deposited and all sums from time to time standing to the credit of the account.
    Personnes ayant droit
    • Roxburgh Holdings Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 06 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 sept. 2021Commencement of winding up
    14 sept. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Henry Anthony Shinners
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Clare Lloyd
    25 Moorgate
    Surrey
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    Surrey
    EC2R 6AY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0