TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04126418 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street EC2V 7BG London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 sept. 2022 | 13 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY à C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG le 05 juil. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gavin Raymond White le 14 juin 2022 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Martin Baddeley le 14 juin 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL United Kingdom à C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY le 01 oct. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Deborah Ann Saunders en tant que secrétaire le 01 sept. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Gavin Raymond White en tant que secrétaire le 01 sept. 2021 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicola Claire Mitford-Slade en tant que directeur le 18 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Woodhouse en tant que directeur le 18 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Nicola Claire Mitford-Slade en tant qu'administrateur le 22 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Donald William Sherret Reid en tant que directeur le 22 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rehana Hasan en tant que secrétaire le 22 oct. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Deborah Ann Saunders en tant que secrétaire le 22 oct. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England à 25 Moorgate London EC2R 6AY | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 9 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Uk Wealth Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Gavin Raymond | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7BG London 45 United Kingdom | 287111660001 | |||||||
| BADDELEY, Andrew Martin | Administrateur | Gresham Street EC2V 7BG London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 82469460001 | |||||
| BELLAMY, Martin William | Secrétaire | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | 173987280001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secrétaire | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197499510001 | |||||||
| HASAN, Rehana | Secrétaire | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | 217675490001 | |||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Secrétaire | 9i Calles Las Palmeras Urb Vista Laguna 11312 Torreguadiaro Cadiz Spain | British | 52538020003 | ||||||
| NICHOLS, Sarah | Secrétaire | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 8 West Yorkshire | British | 157133400001 | ||||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Secrétaire | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | British | 129803720001 | ||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Secrétaire | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 276008310001 | |||||||
| BRADSHAW, Phillip Gordon | Administrateur | Springfield Farm Hardwick Road East Hardwick WF8 3DL Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 26428400002 | |||||
| BUSSEY, Michael Adrian | Administrateur | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | British | 52554700003 | |||||
| CHAPMAN, Andrew | Administrateur | Ask House 88 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 39777190002 | |||||
| COLEMAN, Lynn Rose | Administrateur | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | British | 149721950001 | |||||
| CRESWELL-TURNER, Miles Marius | Administrateur | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | England | British | 160087860001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Administrateur | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| DOWNING, Wadham St. John | Administrateur | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 203301710001 | |||||
| DUFTON, Jeremy Jon | Administrateur | 1 Long Meadow High Ackworth WF7 7EA Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 56706650001 | |||||
| FLETCHER, Alfred Olding | Administrateur | 154a Western Way Darras Hall NE20 9LY Pontelant Northumberland | England | British | 226590003 | |||||
| FRASER, Thomas Aird | Administrateur | Flat 3 20 Lower Sloane Street SW1W 8BJ London | Australian | 74112910002 | ||||||
| HAINSWORTH BREAR, Timothy Austin | Administrateur | Wyndorf 11a Fairway Tranmere Park Guiseley LS20 8JT Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 110677380001 | |||||
| HALL, Peter Lindop | Administrateur | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 212005290001 | |||||
| HERON, Hugh | Administrateur | 114 Carleton Road WF8 3NQ Pontefract West Yorkshire | England | British | 26428410003 | |||||
| HOGG, Andrew | Administrateur | 6 Tranfield Gardens Guiseley LS20 8PZ Leeds West Yorkshire | British | 63356910003 | ||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Administrateur | Brindley House Valley Road Killamarsh S21 1JB Sheffield | British | 52538020002 | ||||||
| JONES, Peter Francis | Administrateur | 15 Wigton Park Close LS17 8UH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 33965180002 | |||||
| MITFORD-SLADE, Nicola Claire | Administrateur | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | United Kingdom | British | 276051890001 | |||||
| MULLORD, Kathleen Francis | Administrateur | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | South African | 160087800001 | |||||
| POLIN, Jonathan Charles | Administrateur | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | Scotland | British | 97840060003 | |||||
| PORTEOUS, John Robert | Administrateur | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 166212270001 | |||||
| REID, Donald William Sherret | Administrateur | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | England | British | 212004930001 | |||||
| SAWYER, Gareth Matthew | Administrateur | 5 Chelmsford Road HG1 5NA Harrogate | United Kingdom | British | 46468670003 | |||||
| SINCLAIR, Richard Harris | Administrateur | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | England | British | 204668540001 | |||||
| TAGLIABUE, Alfio | Administrateur | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | Italian | 76352220004 | |||||
| WOODHOUSE, Christopher | Administrateur | Chesterfield Gardens W1J 5BQ London 6 England England | England | British | 238888480001 | |||||
| WRIGHT, Paul Vernon | Administrateur | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 137936580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Wealth Management Limited | 06 avr. 2016 | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 04 juin 2015 Livré le 11 juin 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Créé le 22 oct. 2002 Livré le 29 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy no RNF00072345A for £200,000 over life of phillip gordon bradshaw with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Créé le 22 oct. 2002 Livré le 29 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy no RNF0072346A for £200,000 over life of hugh heron with all bonuses and benefits thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Créé le 22 oct. 2002 Livré le 29 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy no RNF0072342A for £200,000 over life of andrew hogg with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Créé le 22 oct. 2002 Livré le 29 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy no RNF0072344A for £200,000 over life of peter francis jones with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 02 oct. 2002 Livré le 17 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Licence to assign | Créé le 27 nov. 2001 Livré le 28 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and media works corporation communications LTD to the chargee pursuant to the licence to assign | |
Brèves mentions The sum of £10,350.00 plus vat the account in which the sum is deposited and all sums from time to time standing to the credit of the account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture deed | Créé le 28 févr. 2001 Livré le 06 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0