MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED

MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04129282
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MWB (HOTEL LP SHAREHOLDER) LIMITED18 déc. 200018 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    26 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 nov. 2016

    22 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 nov. 2015

    27 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 nov. 2014

    23 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 nov. 2013

    32 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 juin 2013

    32 pages2.24B

    legacy

    3 pagesMG02

    Résultat de la réunion des créanciers

    1 pages2.23B

    Cessation de la nomination de Michael Bibring en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    63 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * 179 Great Portland Street London W1W 5LS* le 14 déc. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Gail Robson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Jagtar Singh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Balfour-Lynn en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 déc. 2011

    État du capital au 13 déc. 2011

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2010 au 30 juin 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    5 pagesAUD

    Comptes établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secrétaire
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Administrateur
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Administrateur
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Administrateur
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    Administrateur
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    United KingdomBritish121710890001
    FILEX NOMINEES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Administrateur désigné
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    900020280001

    MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 juin 2008
    Livré le 26 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 27 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge its entire right,title and interest in and to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares
    Créé le 10 nov. 2005
    Livré le 29 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mwb business exchange UK limited or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee by way of fixed charge the investments and all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transactions
    • 29 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares
    Créé le 10 nov. 2005
    Livré le 29 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mwb business exchange UK limited or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee by way of fixed charge the investments and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transactions
    • 29 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Shares charge (senior)
    Créé le 01 juil. 2003
    Livré le 22 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal debtor or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable in respect of the investments.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transactions
    • 22 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Shares charge (mezzanine)
    Créé le 01 juil. 2003
    Livré le 22 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal debtor or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable in respect of the investments.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transactions
    • 22 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 23 déc. 2002
    Livré le 10 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mwb business exchange limited or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the shares being 25 shares of £1.00 in the share capital of mwb business exchange limited and all dividends, interest and other money payable to the company in respect of the shares, all of those assets and rights referred to in clause 3 of the share charge.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transactions
    • 10 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 23 déc. 2002
    Livré le 10 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mwb business exchange limited or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the shares being 25 shares of £1.00 in the share capital of mwb business exchange limited and all dividends, interest and other money payable to the company in respect of the shares, all of those assets and rights referred to in clause 3 of the share charge.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transactions
    • 10 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares (senior)
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 04 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of the principal debtor or the chargor owed or expressed to be owed to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent")
    Transactions
    • 04 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares (mezzanine)
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 04 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of the principal debtor or the chargor owed or expressed to be owed to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent")
    Transactions
    • 04 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 nov. 2013Administration ended
    10 déc. 2012Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Philip Stephen Bowers
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DateType
    12 nov. 2013Commencement of winding up
    15 avr. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Philip Stephen Bowers
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    practitioner
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0