ELY CARE HOME LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ELY CARE HOME LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04131023 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ELY CARE HOME LIMITED ?
| Adresse du siège social | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ELY CARE HOME LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour ELY CARE HOME LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 24 juil. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010 | 9 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kamma Foulkes en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur William James Buchan le 27 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Neil Midmer le 27 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Kamma Foulkes le 27 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire William David Mcleish le 27 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ELY CARE HOME LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| ALFLATT, John Neal | Secrétaire | 3 Goldings Lane Waterford SG14 2PT Hertford Hertfordshire | British | 86320800001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secrétaire | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secrétaire | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305550001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secrétaire | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secrétaire | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SLACK, Michael Stephen | Secrétaire | 239 Greenmount Lane BL1 5JB Bolton Lancashire | British | 9265180001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BOLOT, Timothy James | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Administrateur | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Administrateur | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Administrateur | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HANDLEY, David Michael | Administrateur | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 52899270001 | |||||
| JAP, Chee Miau | Administrateur | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LOCK, Jason David | Administrateur | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Administrateur | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| PATEL, Mahesh Shivabhai | Administrateur | 29 The Avenue HA5 5BN Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 80756410001 | |||||
| RUTTER, Christopher | Administrateur | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Administrateur | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Administrateur | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Administrateur | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STOREY, John | Administrateur | 93 Dacre Park Blackheath SE13 5BX London | British | 60123860002 |
ELY CARE HOME LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 05 juil. 2002 Livré le 19 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land on the west side of lynn road ely cambridge CB2 1SD t/no CB232848. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 juil. 2002 Livré le 18 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0