ELY CARE HOME LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéELY CARE HOME LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04131023
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ELY CARE HOME LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ELY CARE HOME LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ELY CARE HOME LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ELY NURSING HOME LIMITED27 déc. 200027 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de ELY CARE HOME LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ELY CARE HOME LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 24 juil. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 déc. 2011

    État du capital au 29 déc. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kamma Foulkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur William James Buchan le 27 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Neil Midmer le 27 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kamma Foulkes le 27 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire William David Mcleish le 27 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de ELY CARE HOME LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    ALFLATT, John Neal
    3 Goldings Lane
    Waterford
    SG14 2PT Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Goldings Lane
    Waterford
    SG14 2PT Hertford
    Hertfordshire
    British86320800001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secrétaire
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305550001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secrétaire
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SLACK, Michael Stephen
    239 Greenmount Lane
    BL1 5JB Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    239 Greenmount Lane
    BL1 5JB Bolton
    Lancashire
    British9265180001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Administrateur
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Administrateur
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HANDLEY, David Michael
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish52899270001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Administrateur
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Administrateur
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Administrateur
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PATEL, Mahesh Shivabhai
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish80756410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Administrateur
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Administrateur
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Administrateur
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002

    ELY CARE HOME LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 2002
    Livré le 19 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the west side of lynn road ely cambridge CB2 1SD t/no CB232848. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0