CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04132389 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?
Adresse du siège social | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton Bedfordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 déc. 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 9 pages | AA | ||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée | 1 pages | CERT10 | ||||||||||
Réenregistrement des statuts | 9 pages | MAR | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée | 2 pages | RR02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Burchall le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rebecca Jane Watson le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Rebecca Jane Watson le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 10 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATSON, Rebecca Jane | Secrétaire | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | Other | 133821050001 | ||||||
BURCHALL, Andrew Jeremy | Administrateur | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 69904570002 | ||||
WATSON, Rebecca Jane | Administrateur | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | England | British | Solicitor | 70686070002 | ||||
OSBORNE, Philip Thomas | Secrétaire | 1715 Bella Vista PO BOX 1764 FOREIGN Belize City Belize | British | 76955710002 | ||||||
PENNINGTON, David Ian | Secrétaire | Ferndene Applelands Close Boundstone GU10 4TL Farnham Surrey | British | Company Secretary | 38346120001 | |||||
ROBINSON, Ian George | Secrétaire | 74 Brookmans Avenue Brookmans Park AL9 7QQ Hatfield Hertfordshire | British | 57975730001 | ||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secrétaire désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
BRADFORD, Richard James | Administrateur | Holcombe House Olney Road MK46 5BX Emberton Buckinghamshire Bucks | United Kingdom | British | Managing Director | 72452740004 | ||||
CHOLERTON, John David | Administrateur | 3 Bryanston Avenue Whitton TW2 6HP Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 9497220001 | ||||
COATES, Jeremy William | Administrateur | 62 The Grove MK40 3JN Bedford Bedfordshire | England | British | Company Director | 58806030001 | ||||
DOYLE, Desmond Mark Christopher | Administrateur | Bagwell Lane RG29 1JG Odiham Green Hill Hampshire | England | British | Director | 266121440001 | ||||
LAWRIE, Stuart | Administrateur | Magpie Cottage Retford Road S81 8ER Blyth Nottinghamshire | British | Company Director | 84516540001 | |||||
PENNINGTON, David Ian | Administrateur | Ferndene Applelands Close Boundstone GU10 4TL Farnham Surrey | England | British | Company Secretary | 38346120001 | ||||
PUGH, Ian Russel | Administrateur | Albury Lodge Warren Drive Kingswood KT20 6PZ Tadworth Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive | 61327530003 | ||||
ROBINSON, Ian George | Administrateur | 74 Brookmans Avenue Brookmans Park AL9 7QQ Hatfield Hertfordshire | England | British | Accountant | 57975730001 | ||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Administrateur désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Administrateur désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 | |||||||
SOUTHTOWN LIMITED | Administrateur | Craigmuir Chambers PO BOX 71 Roadtown Tortola Br Virgin Islands | 70598540001 |
CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 06 mai 2008 Livré le 23 mai 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 06 mai 2008 Livré le 17 mai 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A deed of charge and memorandum of deposit between the depositors and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the"security trustee") for the secured parties (as defined) | Créé le 12 mars 2001 Livré le 30 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations of the depositors to the chargee under or in respect of the credit agreement the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each depositor under the deed (in each case whether in respect of principal interest fees taxes costs expenses or indemnities and whether present or future or actual or contingent) all terms as defined | |
Brèves mentions All the undertaking and all the assets rights income goodwill of the chargor both present and future see the mortgage charge document or full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A deed of floating charge | Créé le 01 mars 2001 Livré le 20 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or inrespect of the credit agreement the guarantee and other loan documents (all as defined) | |
Brèves mentions Floating charge all the undertaking and all the assets rights income and goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0