CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED

CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04132389
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) PLC01 juin 200301 juin 2003
    L.I. HOLDINGS (UK) PLC12 déc. 200112 déc. 2001
    LI HOLDINGS (UK) LIMITED26 févr. 200126 févr. 2001
    ALNERY NO. 2125 LIMITED29 déc. 200029 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 déc. 2011

    8 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2012

    État du capital au 06 janv. 2012

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    10 pagesAA

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    9 pagesMAR

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée

    2 pagesRR02

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Burchall le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Rebecca Jane Watson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Rebecca Jane Watson le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor70686070002
    OSBORNE, Philip Thomas
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    Secrétaire
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    British76955710002
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    BritishCompany Secretary38346120001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Secrétaire
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    British57975730001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secrétaire désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    Administrateur
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritishManaging Director72452740004
    CHOLERTON, John David
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director9497220001
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director58806030001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Administrateur
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritishDirector266121440001
    LAWRIE, Stuart
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director84516540001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary38346120001
    PUGH, Ian Russel
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive61327530003
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant57975730001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001
    SOUTHTOWN LIMITED
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    Administrateur
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    70598540001

    CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 mai 2008
    Livré le 23 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Trusgtee (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 23 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 mai 2008
    Livré le 17 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    A deed of charge and memorandum of deposit between the depositors and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the"security trustee") for the secured parties (as defined)
    Créé le 12 mars 2001
    Livré le 30 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of the depositors to the chargee under or in respect of the credit agreement the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each depositor under the deed (in each case whether in respect of principal interest fees taxes costs expenses or indemnities and whether present or future or actual or contingent) all terms as defined
    Brèves mentions
    All the undertaking and all the assets rights income goodwill of the chargor both present and future see the mortgage charge document or full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia as Agent and Security Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 30 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of floating charge
    Créé le 01 mars 2001
    Livré le 20 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or inrespect of the credit agreement the guarantee and other loan documents (all as defined)
    Brèves mentions
    Floating charge all the undertaking and all the assets rights income and goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 20 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0