GOALCYCLE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOALCYCLE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04135963
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOALCYCLE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GOALCYCLE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Latimer House
    5 Cumberland Place
    SO15 2BH Southampton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GOALCYCLE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GOALCYCLE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GOALCYCLE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pages4.72

    Changement d'adresse du siège social de C/O James Cowper Llp 1 Fetter Lane London EC4A 1BR à Latimer House 5 Cumberland Place Southampton SO15 2BH le 15 nov. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 oct. 2014

    11 pages4.68

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Changement d'adresse du siège social de * Oriel Buildings 10 Margaret Street London W1W 8RL United Kingdom* le 30 oct. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2013

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2013

    État du capital au 11 janv. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Dls Accounting Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Anthony Midgen en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Anthony Midgen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor, 43-44 Berners Street London W1T 3ND* le 13 juin 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Michael Midgen le 06 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Anthony Midgen en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Nicholas Check en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de GOALCYCLE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DLS ACCOUNTING SERVICES LIMITED
    Cowdown Business Park
    Micheldever
    SO21 3DN Winchester
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cowdown Business Park
    Micheldever
    SO21 3DN Winchester
    4
    Hampshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06894920
    172184410001
    MIDGEN, Selwyn Isaac
    38 West Hill Park
    Merton Lane
    N6 6ND London
    Administrateur
    38 West Hill Park
    Merton Lane
    N6 6ND London
    EnglandBritishChartered Surveyor50954120003
    BENNETT, Jeremy Philip
    16 Ashburnham Road
    TN10 3DU Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    16 Ashburnham Road
    TN10 3DU Tonbridge
    Kent
    British57810940002
    CHECK, Nicholas Howard
    4 Honiton Gardens
    Mill Hill
    NW7 1GF London
    Secrétaire
    4 Honiton Gardens
    Mill Hill
    NW7 1GF London
    British89626490001
    MIDGEN, Anthony
    Pembroke Gardens Close
    W8 6HR London
    27
    United Kingdom
    Secrétaire
    Pembroke Gardens Close
    W8 6HR London
    27
    United Kingdom
    156777890001
    TAYLOR, Mark Robert
    24 Cricket Road
    OX4 3DG Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    24 Cricket Road
    OX4 3DG Oxford
    Oxfordshire
    BritishAccountant79270070002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    MIDGEN, Anthony Michael
    27 Pembroke Gardens Close
    W8 6AR London
    Administrateur
    27 Pembroke Gardens Close
    W8 6AR London
    United KingdomBritishSolicitor4332030002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GOALCYCLE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment
    Créé le 20 déc. 2007
    Livré le 22 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title benefits and interest to all moneys from time to time owing under the leases in respect of f/h property k/a park house friar lane nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transactions
    • 22 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed
    Créé le 20 déc. 2007
    Livré le 22 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a park house friar lane nottingham - part NT98038 part land together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transactions
    • 22 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 nov. 2007
    Livré le 06 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the donington investments (nottingham) limited and the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property being maid marian house maid marian way nottingham - NT124944 including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant equipment and machinery all moneys deposited and by way of floating charge the property assets rights and revenues.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transactions
    • 06 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 117 sept. 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 118 janv. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 1
    Deed of assignment
    Créé le 26 nov. 2007
    Livré le 06 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from donington investments (nottingham) limited and the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title benefits and intereststo all moneys from time to time owing or incurred under the leases in respect of the f/h property being maid marion hous. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transactions
    • 06 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 mars 2001
    Livré le 04 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of the chargor owed or expressed to be owed to the bank or an associated company whether or not originally owed to the bank or an associated company and whether owed jointly or severally as principal or surety or in any other capacity
    Brèves mentions
    The property k/a 50-58 (even numbers) victoria road horley surrey t/no SY529728. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation
    Transactions
    • 04 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GOALCYCLE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan Green
    Elliot House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    receiver manager
    Elliot House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    Richard James Stanley
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    receiver manager
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Jemma Kathleen Mcandrew
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    receiver manager
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    2
    DateType
    23 oct. 2013Commencement of winding up
    23 févr. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan Peter Whalley
    James Cowper Llp
    1 Fetter Lane
    EC4A 1BR London
    practitioner
    James Cowper Llp
    1 Fetter Lane
    EC4A 1BR London
    Sandra Lillian Mundy
    James Cowper Kreston 1 Fetter Lane
    EC4A 1BR London
    practitioner
    James Cowper Kreston 1 Fetter Lane
    EC4A 1BR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0