ACREPINE PROPERTIES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéACREPINE PROPERTIES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04144728
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ACREPINE PROPERTIES LTD ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe ACREPINE PROPERTIES LTD ?

    Adresse du siège social
    28 Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ACREPINE PROPERTIES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 oct. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour ACREPINE PROPERTIES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes de micro-entité établis au 30 oct. 2019

    3 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Notification de Rasik Bakrania en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mars 2020

    2 pagesPSC01

    Notification de Kamlesh Rasik Bakrania en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 juin 2018

    2 pagesPSC01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Changement d'adresse du siège social de 11 Albemarle Road East Barnet Barnet EN4 8EQ England à 28 Albemarle Road East Barnet Barnet EN4 8EG le 19 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 30 oct. 2018

    2 pagesAA

    Comptes de micro-entité établis au 30 oct. 2017

    2 pagesAA

    Comptes de micro-entité établis au 30 oct. 2016

    2 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 oct. 2016 au 30 oct. 2016

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de 28 Albemarle Road East Barnet Herts EN4 8EG à 11 Albemarle Road East Barnet Barnet EN4 8EQ le 24 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2015

    4 pagesAA

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 18 août 2015

    2 pages3.6

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juil. 2015

    État du capital au 20 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 18 févr. 2015

    2 pages3.6

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 juil. 2014

    État du capital au 31 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012

    4 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 juil. 2012 au 31 oct. 2012

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 avr. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 10 avr. 2013

    SH01

    Qui sont les dirigeants de ACREPINE PROPERTIES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAKRANIA, Rasik
    28 Albemarle Road
    EN4 8EG East Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    28 Albemarle Road
    EN4 8EG East Barnet
    Hertfordshire
    BritishBusiness54248440001
    BAKRANIA, Kamlesh
    28 Albemarle Road
    EN4 8EG East Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    28 Albemarle Road
    EN4 8EG East Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritishProperty Investment56024290001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BAKRANIA, Pravin Ranchhodbhai
    8 Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestor68095660001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ACREPINE PROPERTIES LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Rasik Bakrania
    Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    28
    England
    04 mars 2020
    Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    28
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mrs Kamlesh Rasik Bakrania
    Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    28
    England
    02 juin 2018
    Albemarle Road
    East Barnet
    EN4 8EG Barnet
    28
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    ACREPINE PROPERTIES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Basil court station road new barnet the benefit of rights licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property - any shares or membership rights relating to the property - any goodwill of any business from time to time carried on at the property - any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property and any other payments whatever in respect of the property for example payments from insurance policy or any compensation money.
    Personnes ayant droit
    • The Cyprus Popular Bank Public Company Limited
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 127 févr. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 102 nov. 2019Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 102 nov. 2019Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 10 juil. 2005
    Livré le 23 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts buildings plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Cyprus Popular Bank Public Company LTD
    Transactions
    • 23 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 2004
    Livré le 23 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 16 basil court, 1 station road, new barnet, herts, EN5 1NG,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 9 basil court, 1 station road, new barnet, herts EN5 1NG,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 17 basil court 1 station road new barnet herts EN5 1NG,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 04 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 04 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as basil court 1 station road nw garnet herts EN5 1NG and the leasehold flats numberes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 & 50 basil court 1 station road new barnet herts EN5 1NG. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ACREPINE PROPERTIES LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Yiannis Koumettou
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    receiver manager
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    Ninos Koumettou
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London
    receiver manager
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0