J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04153386 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey EC4M 7AU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 nov. 2022 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/Omazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD à C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 13 mai 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 nov. 2021 | 12 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP à Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD le 03 déc. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 14 juil. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 15 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Richard Hobson en tant que directeur le 02 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Richard Hobson le 01 oct. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Steven Allen en tant qu'administrateur le 01 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de James Anthony Paul Chatters en tant qu'administrateur le 01 août 2017 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom |
| 131351630001 | ||||||||||
| ALLEN, Mark Steven | Administrateur | Old Bailey EC4M 7AU London C/O Mazars Llp, 30 | England | British | 235236620002 | |||||||||
| CHATTERS, James Anthony Paul | Administrateur | Old Bailey EC4M 7AU London C/O Mazars Llp, 30 | England | British | 236513520001 | |||||||||
| EARL, Jane | Secrétaire | Jpmorgan Cazenove Holdings 20 Moorgate EC2R 6DA London | British | 82548680002 | ||||||||||
| MADLE, Geoffrey | Secrétaire | Moorgate EC2R 6DA London 20 | British | 138528100001 | ||||||||||
| POWER, Michael Richard Parkes | Secrétaire | Oakwood Farm Shipley RH13 8PY Horsham West Sussex | British | 163435880001 | ||||||||||
| PRYOR, Sophia Elizabeth Sarah | Secrétaire | Moorgate EC2R 6DA London 20 | British | 123427600002 | ||||||||||
| BERLIAND, Richard David Antony | Administrateur | 125 London Wall EC2Y 5AJ London Jp Morgan | England | British | 53438570002 | |||||||||
| BISHOP, Charles Richard Maurice | Administrateur | Pundicts Lodge Braxted Park, Great Braxted CM8 3EN Witham Essex | British | 142860010001 | ||||||||||
| BROWN, James Thomas | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 | England | British | 75423840002 | |||||||||
| BYERS, Edmund Witold | Administrateur | Ashton Farm Ashton Lane Bishops Waltham SO32 1FR Southampton Hampshire | England | British | 173288310001 | |||||||||
| CARRUTHERS, Alan Thomas | Administrateur | 10 Birds Hill Drive KT22 0SP Oxshott Surrey | British | 141640320001 | ||||||||||
| CARRUTHERS, Alan Thomas | Administrateur | 10 Birds Hill Drive KT22 0SP Oxshott Surrey | British | 141640320001 | ||||||||||
| COLENUTT, John Edward Balfour | Administrateur | Park Close 23 Rothamsted Avenue AL5 2DN Harpenden Hertfordshire | England | British | 141844080001 | |||||||||
| COLENUTT, John Edward Balfour | Administrateur | Park Close 23 Rothamsted Avenue AL5 2DN Harpenden Hertfordshire | England | British | 141844080001 | |||||||||
| FELL, David Hamilton | Administrateur | 1 All Saints Road W11 1HA London | British | 58274420004 | ||||||||||
| HOBSON, John Richard | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | Luxembourg | British | 186338280013 | |||||||||
| HOLLINGWORTH, Laurence David Edgar | Administrateur | Woolstone Lodge Woolstone SN7 7QL Faringdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 141412200001 | |||||||||
| KHERAJ, Naguib | Administrateur | Eccleston Square SW1V 1PB London 34a | British | 24278650014 | ||||||||||
| KNOX, David Paul | Administrateur | Old Walls Woodland Rise TN15 0JB Sevenoaks Kent | England | British | 141412220001 | |||||||||
| KORABLINA, Elena | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 169338820002 | |||||||||
| MAYHEW, David Lionel | Administrateur | Jpmorgan Cazenove Holdings 20 Moorgate EC2R 6DA London | United Kingdom | British | 68834270003 | |||||||||
| MCKERRELL, Alasdair Alan Dewar | Administrateur | Ongars Dunmow Road Hatfield Heath CM22 7EE Bishops Stortford Hertfordshire | British | 43616810001 | ||||||||||
| MEADOWS, Graham John | Administrateur | 20 Moorgate London EC2R 6DA | United Kingdom | British | 55611900003 | |||||||||
| MELLING, Matthew Paul | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 187815840001 | |||||||||
| NEVILLE, Matthew David | Administrateur | 20 Chepstow Villas W11 2RB London | British | 141443020001 | ||||||||||
| PAYNTER, John Gregor Hugh | Administrateur | 32 Drayton Gardens SW10 9SA London | United Kingdom | British | 6722060003 | |||||||||
| PICKERING, Robert Mark | Administrateur | Jpmorgan Cazenove Holdings 20 Moorgate EC2R 6DA London | United Kingdom | British | 74181950002 | |||||||||
| POWER, Michael Richard Parkes | Administrateur | Jpmorgan Cazenove Holdings 20 Moorgate EC2R 6DA London | United Kingdom | British | 3504160002 | |||||||||
| ROWE, Nigel | Administrateur | 7 Ormond Road TW10 6TH Richmond Surrey | British | 24877680001 | ||||||||||
| STOTT, Jakob Thomsen | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 | United Kingdom | Danish | 126661630001 | |||||||||
| TURMAINE, David | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | England | British | 153060140002 | |||||||||
| VEREY, David John, Sir | Administrateur | 3 Airlie Gardens W8 7AJ London | England | British | 4769330001 | |||||||||
| WHITE, Stephen Michael | Administrateur | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 172285460001 | |||||||||
| WILES, Nicholas Winston Braid | Administrateur | 10 Westmoreland Terrace SW1V 4AF London | British | 84657530001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpmorgan Cazenove Holdings | 06 avr. 2016 | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed creating charges over crest stock (gilts and equities) and receivables | Créé le 24 oct. 2003 Livré le 06 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all right (including property rights) title and interest by way of first floating charge all eligible stock. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system | Créé le 26 févr. 2002 Livré le 08 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the euroclear bank S.A./N.V. On its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
J.P. MORGAN CAZENOVE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0