JSE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJSE DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04163466
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OVAL (1628) LIMITED20 févr. 200120 févr. 2001

    Quels sont les derniers comptes de JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 55 Baker Street London W1U 7EU à 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE le 15 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2015

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    3 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mai 2014

    État du capital au 02 mai 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Meridien House 42 Upper Berkeley Street London W1H 5EP United Kingdom* le 24 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robert Game en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Keogh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert William Game le 01 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark William Keogh le 01 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Nomination de Kevin Martin Amor en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Jonathan Edward Taylor en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Cargil Management Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de David Lanchester en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE* le 11 janv. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de JSE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    Secrétaire
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02601236
    38636470004
    AMOR, Kevin Martin
    Wootton Lane
    HP17 8UY Dinton
    3
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    Wootton Lane
    HP17 8UY Dinton
    3
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant94937180002
    BAILEY, Clive Henry
    Laburnum House 289 Rectory Road
    Hawkwell
    SS5 4LA Hockley
    Essex
    Administrateur
    Laburnum House 289 Rectory Road
    Hawkwell
    SS5 4LA Hockley
    Essex
    EnglandBritishManagement Accountant96018870001
    MAIKLEM, Miles Richard
    Eagle Way
    Warley
    CM13 3BW Brentwood
    1/653 Central Office
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Eagle Way
    Warley
    CM13 3BW Brentwood
    1/653 Central Office
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishMarketing Manager70637730001
    TAYLOR, Jonathan Edward
    High Street
    HP17 8UN Dinton
    Mount Pleasant
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    HP17 8UN Dinton
    Mount Pleasant
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor139346680001
    GARDNER, Kamla Devi
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    Secrétaire
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    BritishAccountant81242540002
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Secrétaire
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    PAEGETTER, Craoig Peter
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    Secrétaire
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    BritishDirector77025280001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant26086560001
    GAME, Robert William
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    Administrateur
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    United KingdomEnglishChartered Surveyor139555050001
    GARDNER, Kamla Devi
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    Administrateur
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    BritishAccountant81242540002
    KEOGH, Mark William
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    Administrateur
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    EnglandIrishChartered Accountant62140690001
    PAEGETTER, Craoig Peter
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    Administrateur
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    BritishDirector77025280001
    PROWTING, Roger George
    68 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    68 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishChartered Management Accountan76592730001
    ROSCOE, Antony David
    24 Hillcroft Crescent
    W5 2SQ London
    Administrateur
    24 Hillcroft Crescent
    W5 2SQ London
    EnglandBritishDirector52996620001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Administrateur
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritishAccountant5689250001
    WEST, Stuart Charles
    Hailstone Close
    Hadlow
    TN11 0JY Tonbridge
    22
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Hailstone Close
    Hadlow
    TN11 0JY Tonbridge
    22
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishMarketing Manager130728390001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 26 mars 2010
    Livré le 01 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The properties k/a 3 to 5 mount ephraim and 5,6,7 and 8 culverdon street tunbridge wells t/no K733530. 12 invencible road farnborough t/no HP373809. 53 and 55 bishopric and land k/s tansfield bishopric t/no WSX124835.for further properties charged please refer to form MG01 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 16 août 2007
    Livré le 28 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 12 invincible road farnborough t/no HP373809, f/h property k/A53-59 bishopric horsham t/nos WSX124835ANS WSX144118, f/h property k/a aveburyavenue tonbridge t/no K462990 and f/h property k/a 3-15 (odd) mount ephraim AND5-8 culverden street tunbridge t/no K733. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 mai 2001
    Livré le 26 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from james smith estates PLC to the chargee under the facility letter dated 27 april 2001
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 12 invincible road farnborough hampshire t/n HP373809, an assignment of the rental sums, a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 2001
    Livré le 19 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities which are now or in the future due, owing or incurred by the borrower to the bank under the facility letter dated 27 april 2001 (including any renewal or replacement facility letter referred to as the "facility letter")
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the l/h property k/a 3-15 (odd) mount ephraim and 5, 6, 7 & 8 culverden street tunbridge wells t/n K733530 an assignment of the rental sums together with the benefit of all the company's rights and remedies relating to them a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 2001
    Livré le 19 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities which are now or in the future due, owing or incurred by the borrower to the bank under the facility letter dated 27 april 2001 (including any renewal or replacement facility letter referred to as the "facility letter")
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 53/59 bishopric, horsham, west sussex t/ns WSX124835 and WSX144118 an assignment of the rental sums together with the benefit of all the company's rights and remedies relating to them a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 2001
    Livré le 19 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities which are now or in the future due, owing or incurred by the borrower to the bank under the facility letter dated 27 april 2001 (including any renewal or replacement facility letter referred to as the "facility letter")
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the l/h property k/a land and buildings on the south side of avebury avenue, tonbridge t/n K462990 an assignment of the rental sums together with the benefit of all the company's rights and remedies relating to them a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 2001
    Livré le 12 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due owing or incurred by james smith estates PLC (the borrower) to the chargee under the facility letter issued by the chargee to the borrower on 27 april 2001
    Brèves mentions
    F/H property k/a 128 high road woodford redbridge including all buildings and structures and fixtures (including trade and tenant's fixtures) rental sums and all plant machinery and other fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 2001
    Livré le 12 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due owing or incurred by james smith estates PLC (the borrower) to the chargee under the facility letter issued by the chargee to the borrower on 27 april 2001
    Brèves mentions
    L/H property k/a the interior of the underground car park at 140 high road woodford redbridge - EGL342062 including all buildings and structures and fixtures (including trade and tenant's fixtures and rental sums and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2015Commencement of winding up
    12 juil. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Newman
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    practitioner
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Vincent John Green
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    practitioner
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0