CPS NUMBER 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCPS NUMBER 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04165720
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CPS NUMBER 2 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CPS NUMBER 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CPS NUMBER 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALNERY NO.2161 LIMITED22 févr. 200122 févr. 2001

    Quels sont les derniers comptes de CPS NUMBER 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CPS NUMBER 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 48a Cambridge Road Hapag-Lloyd House Barking Essex IG11 8HH le 17 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 juil. 2012

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2012

    État du capital au 08 mai 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs. Joyce Walter le 18 mars 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr. Andrew Lloyd John en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs. Joyce Walter en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mrs. Joyce Walter en tant qu'administrateur

    1 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Mansfeld en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Michael Reeve en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de CPS NUMBER 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALTER, Joyce, Mrs.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Hampshire
    Secrétaire
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Hampshire
    149355380001
    JOHN, Andrew Lloyd
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Hampshire
    Administrateur
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Hampshire
    EnglandBritishLawyer75467790003
    RAU, Wilfried
    Hannover
    Bischofsholer Damm 34
    30173
    Germany
    Administrateur
    Hannover
    Bischofsholer Damm 34
    30173
    Germany
    GermanyGermanDirector136733410001
    WALTER, Joyce
    Alexander Crescent
    The Village
    CR35ZG Caterham
    25
    Surrey
    Administrateur
    Alexander Crescent
    The Village
    CR35ZG Caterham
    25
    Surrey
    EnglandBritishChartered Secretary76169540002
    BAKER, John Michael
    Pedlars
    The Chase
    KT20 6HZ Kingswood
    Surrey
    Secrétaire
    Pedlars
    The Chase
    KT20 6HZ Kingswood
    Surrey
    Canadian110901170001
    HILL, Elliot Robert Greatrex
    Flat 1
    143 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    Secrétaire
    Flat 1
    143 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    British99461490001
    MANSFELD, Thomas
    Zikadenweg
    FOREIGN 22043 Hamburg
    19e
    Germany
    Secrétaire
    Zikadenweg
    FOREIGN 22043 Hamburg
    19e
    Germany
    German117835010002
    SHARMAN, Carl John
    6 Days Green
    Capel St Mary
    IP9 2HZ Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    6 Days Green
    Capel St Mary
    IP9 2HZ Ipswich
    Suffolk
    BritishChartered Accountant74436380003
    SHORT, Karen Margot
    The Tythe Barn
    TN21 9RG Rushlake Green
    East Sussex
    Secrétaire
    The Tythe Barn
    TN21 9RG Rushlake Green
    East Sussex
    BritishAccountant78988930002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secrétaire désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BOYLAN, Alan Francis
    361 Chambersbury Lane
    HP3 8LW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    361 Chambersbury Lane
    HP3 8LW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishDirector105598290003
    HARDS, Glenn
    36 Ratton Drive
    BN20 9BS Eastbourne
    East Sussex
    Administrateur
    36 Ratton Drive
    BN20 9BS Eastbourne
    East Sussex
    BritishDirector102419860001
    KNIGHTLEY, Ian Geoffrey
    5 Old Rectory Gardens
    Occold
    IP23 7PD Eye
    Suffolk
    Administrateur
    5 Old Rectory Gardens
    Occold
    IP23 7PD Eye
    Suffolk
    BritishDirector74138000001
    KRANICH, Ulrich
    Weidenkamp 4
    Handorf
    21447
    Germany
    Administrateur
    Weidenkamp 4
    Handorf
    21447
    Germany
    GermanyGermanDirector108535400001
    NICKLIN, David Royston
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    Administrateur
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    BritishDirector78465650001
    NICKLIN, David Royston
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    Administrateur
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    BritishDirector78465650001
    REEVE, Michael
    11 Tiberius Gardens
    CM8 1HJ Witham
    Essex
    Administrateur
    11 Tiberius Gardens
    CM8 1HJ Witham
    Essex
    EnglandBritishDirector60778110001
    TORRENS, Iain William
    34 Church Avenue
    East Sheen
    SW14 8NN London
    Administrateur
    34 Church Avenue
    East Sheen
    SW14 8NN London
    BritishDirector83364810001
    WALDING, Keith John
    Kintail
    Halldore Hill
    SL6 9EX Cookham
    Berkshire
    Administrateur
    Kintail
    Halldore Hill
    SL6 9EX Cookham
    Berkshire
    BritishDirector46199600003
    WEBBER, Ian James
    The Farmyard
    Pearsons Green
    TN12 7DE Brenchley
    Kent
    Administrateur
    The Farmyard
    Pearsons Green
    TN12 7DE Brenchley
    Kent
    BritishDirector54611490002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    CPS NUMBER 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of covenant
    Créé le 03 août 2005
    Livré le 10 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel canmar honour official number 731215 and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V
    Transactions
    • 10 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Ship mortgage
    Créé le 03 août 2005
    Livré le 10 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel canmar honour official number 731215 all of the company's share or interest in that vessel and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V
    Transactions
    • 10 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of covenant
    Créé le 25 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the chargee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "contship aurora" register under official number 906102 and includes all the share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Ship mortgage
    Créé le 25 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "contship aurora" register under official number 906102 and includes all the share or interest in that vessel and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority statutory british ship mortgage
    Créé le 18 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "canmar pride" registered in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 731216 and includes all of the company's shares or interest in that vessel and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 18 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "canmar pride" registered in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 731216 and includes any of the owner's share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired by the owner.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority statutory british ship mortgage
    Créé le 15 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "contship australis" registered in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906103 and includes all of the company's shares or interest in that vessel and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 15 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "contship australis" registered in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906104 and includes any of the owner's share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired by the owner.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority statutory british ship mortgage
    Créé le 14 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "contship borealis" registered in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906104 and includes all of the company's shares or interest in that vessel and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 14 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers, security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the vessel "contship borealis" registered in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906103 and includes any of the owner's share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired by the owner.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 31 mars 2004
    Livré le 07 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due or to become due from the borrowers,the security parties or any of them to the chargee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All undertaking,assets and rights whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 07 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General assignment
    Créé le 31 mars 2004
    Livré le 07 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due or to become due from the borrowers,the security parties or any of them to the chargee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights and interests of the assignor in connection with the charterer's insurances and any requisition compensation; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 07 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant collateral to a first priority bermuda statutory ship mortgage dated the same as the deed
    Créé le 06 sept. 2001
    Livré le 18 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due from the borrowers, the secured parties (as defined) or any of them to the chargee or any other creditor party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The vessel "cast progress" registered in bermuda under official number 727435 with all her engines,machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank International PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General assignment
    Créé le 06 sept. 2001
    Livré le 18 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due from the borrowers, the secured parties (as defined) or any of them to the chargee or any other creditor party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    All rights band interests whatsoever which the owner has to or in connection with the earnings of the ship,as defined,the insurances,any charter,charter guarantee and any requisition compensation for the ship thereon (all terms as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank International PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A first priority bermuda statutory ship mortgage
    Créé le 06 sept. 2001
    Livré le 18 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities due from the borrowers, the secured parties (as defined) or any of them to the chargee or any other creditor party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The ship "cast progress",registered in bermuda with official no.727435 With all interest,engines,machinery,boats,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank International PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 06 sept. 2001
    Livré le 18 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities which the borrowers,the secured parties (as defined) or any of them have to the chargee or any other creditor party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank International PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CPS NUMBER 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juil. 2012Commencement of winding up
    03 janv. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0