REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Receveur désigné |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04171845 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED ?
Adresse du siège social | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 28 févr. 2011 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 nov. 2011 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2010 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 mars 2017 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 mars 2017 |
En retard | Oui |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
legacy | 3 pages | LQ01 | ||||||||||
legacy | 2 pages | LQ02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Valad Secretarial Services Limited en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Valsec Director Limited en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Bearman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | LQ01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 09 déc. 2010 | 3 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 16 sept. 2010 | 3 pages | CH04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 02 mars 2010 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 02 mars 2010 | 2 pages | CH02 | ||||||||||
Nomination de Mr Christian James Alexander Bearman en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Maddy en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de James Edward Maddy en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Didier Tandy en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Didier Michel Tandy le 22 oct. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Didier Michel Tandy le 07 oct. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 9 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 6 pages | 288a | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI CIACCA, Cesidio Martin | Secrétaire | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
MCCABE, Sandra | Secrétaire | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
A B & C SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||||||
VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520001 | ||||||||||
BEARMAN, Christian James Alexander | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | Chief Operating Officer-Europe | 110436370002 | ||||||||
DI CIACCA, Cesidio Martin | Administrateur | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | Solicitor | 1267050001 | ||||||||
GILMAN, Peter John | Administrateur | The Sashes Holgate Lane Boston Spa LS23 6BN Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 35528040001 | ||||||||
LIGHTBODY, Bruce Robson | Administrateur | 148 Almsford Drive HG2 8EE Harrogate North Yorkshire | British | Solicitor | 75214270001 | |||||||||
MADDY, James Edward | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 137459000001 | ||||||||
MCCABE, Kevin Charles | Administrateur | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | Chartered Surveyor | 109250000001 | |||||||||
MCCABE, Simon Charles | Administrateur | 5 Rothesay Mews EH3 7SG Edinburgh | British | Development Executive | 103888320001 | |||||||||
SHEPHERD, Marcus Owen | Administrateur | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | Charterd Accountants | 41925000003 | ||||||||
TANDY, Didier Michel | Administrateur | Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House 20 North Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||||||
TANDY, Didier Michel | Administrateur | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||||||
INHOCO FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 | |||||||||||
VALSEC DIRECTOR LIMITED | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 102622300002 |
REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture and guarantee | Créé le 28 juin 2006 Livré le 12 juil. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company the chargors and each of them to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The l/h property at plot 1175 thorpe park leeds t/n WYK734083, part of plot 1250 thorpe park leeds t/n WYK691297, plot 2100 thorpe park leeds t/n WYK691298, for details of further properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Legal charge | Créé le 28 févr. 2005 Livré le 12 mars 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from a debtor to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The land known as plot 2100 century way thorpe park leeds t/n WYK691298,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 12 déc. 2001 Livré le 27 déc. 2001 | En cours | Montant garanti All monies and liabilities due or to become due from the company and remote properties 2100 (b) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The leasehold property known as plot 2100 thorpe park leeds comprised in a lease dated 24 march 2001 and a supplemental lease dated 5 december 2001. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 mars 2001 Livré le 10 avr. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2100 (a) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
REMOTE PROPERTIES 2100 (A) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Receiver/Manager appointed |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0