REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED

REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04171982
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INHOCO 2268 LIMITED02 mars 200102 mars 2001

    Quels sont les derniers comptes de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 févr. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes30 nov. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2010

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au02 mars 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation16 mars 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    legacy

    3 pagesLQ01

    legacy

    2 pagesLQ02

    Cessation de la nomination de Valad Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Valsec Director Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christian Bearman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesLQ01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2011

    État du capital au 04 mars 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 09 déc. 2010

    3 pagesCH04

    Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2010

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 16 sept. 2010

    3 pagesCH04

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 02 mars 2010

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 02 mars 2010

    2 pagesCH04

    Nomination de Mr Christian James Alexander Bearman en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Maddy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de James Edward Maddy en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Didier Tandy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Didier Michel Tandy le 22 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Didier Michel Tandy le 07 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    9 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    6 pages288a

    Qui sont les dirigeants de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Secrétaire
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    NAIK, Varsha
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    British101693390001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    BEARMAN, Christian James Alexander
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish110436370002
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish72399980002
    GILMAN, Peter John
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish35528040001
    LIGHTBODY, Bruce Robson
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    British75214270001
    MADDY, James Edward
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish137459000001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OLIVER, Paul Francis
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    Administrateur
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    United KingdomBritish14735150002
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Administrateur
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    British100816670001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300002

    REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture and guarantee
    Créé le 28 juin 2006
    Livré le 12 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the chargors and each of them to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The l/h property at plot 1175 thorpe park leeds t/n WYK734083, part of plot 1250 thorpe park leeds t/n WYK691297, plot 2100 thorpe park leeds t/n WYK691298, for details of further properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capmark Bank Europe PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 12 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 127 mai 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 115 mars 2013Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
    • 115 mars 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 10 avr. 2003
    Livré le 11 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 mars 2003
    Livré le 17 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 1250 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot 1250 thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 1250 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)

    REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Hugh Lawrence Dorins
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Robert Stokely
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0