OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04172887
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    Adresse du siège social
    Office 7 37-39 Shakespeare Street
    PR8 5AB Southport
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2019
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2020
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 févr. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 mars 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au28 févr. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018

    7 pagesAA

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge 8

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge 4

    2 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge 3

    2 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2018 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Julie Ann Williams le 14 déc. 2016

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 févr. 2016

    État du capital au 29 févr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Julie Ann Williams le 07 août 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Julie Ann Williams le 07 août 2015

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mars 2015

    État du capital au 16 mars 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 mars 2014

    État du capital au 24 mars 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 17 févr. 2014

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 17 févr. 2014

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Qui sont les dirigeants de OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Julie Ann
    The Crimps
    SY12 0NB Ellesmere
    Lea Wood Cottage
    Shropshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Crimps
    SY12 0NB Ellesmere
    Lea Wood Cottage
    Shropshire
    United Kingdom
    British76967130001
    GRINDLEY, David Keith
    289 Wigan Road
    WN4 9ST Ashton-In-Makerfield
    Administrateur
    289 Wigan Road
    WN4 9ST Ashton-In-Makerfield
    United KingdomBritish76967080004
    WILLIAMS, Julie Ann
    The Crimps
    SY12 0NB Ellesmere
    Lea Wood Cottage
    Shropshire
    Great Britain
    Administrateur
    The Crimps
    SY12 0NB Ellesmere
    Lea Wood Cottage
    Shropshire
    Great Britain
    EnglandBritish76967130003
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    David Keith Grindley
    37-39 Shakespeare Street
    PR8 5AB Southport
    Office 7
    Merseyside
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    37-39 Shakespeare Street
    PR8 5AB Southport
    Office 7
    Merseyside
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mrs Julie Ann Williams
    37-39 Shakespeare Street
    PR8 5AB Southport
    Office 7
    Merseyside
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    37-39 Shakespeare Street
    PR8 5AB Southport
    Office 7
    Merseyside
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 15 juin 2009
    Livré le 17 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    295 wigan road ashton in makerfield wigan t/no:MAN6139 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 202 oct. 2012Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 220 févr. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 29 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
      • Numéro de dossier 2
    Legal mortgage
    Créé le 15 juin 2009
    Livré le 17 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    15 millingford grove ashton in makerfield wigan assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 102 oct. 2012Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 120 févr. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 29 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
      • Numéro de dossier 1
    Debenture
    Créé le 09 avr. 2009
    Livré le 28 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2018L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 20 juin 2008
    Livré le 23 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    295 wigan road ashton in makerfield wigan by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 20 juin 2008
    Livré le 23 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    15 millingford grove ashton in makerfield wigan by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge
    Créé le 07 avr. 2006
    Livré le 08 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £70000.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    48 whitledge rd, ashton in makerfield, wigan. Fixed charge over all rental income and.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 07 avr. 2006
    Livré le 08 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    £60,000.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    80 wigan road, ashton in makerfield, wigan. Fixed charge over all rental income and.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2018L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 2002
    Livré le 08 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    80 wigan road ashton in makerfield t/no.GM884583. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2018L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 2002
    Livré le 24 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    80 wigan rd,ashton in makerfield; gm 884583. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 11 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    48 whiteledge road bryn wigan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    OLDHOLLY DEVELOPMENTS LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Stanley
    C/O Begbies Traynor (Central) Llp, 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    receiver manager
    C/O Begbies Traynor (Central) Llp, 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Gary Norton Lee
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    receiver manager
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Stanley
    C/O Begbies Traynor (Central) Llp, 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    receiver manager
    C/O Begbies Traynor (Central) Llp, 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Gary Norton Lee
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    receiver manager
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0