KM RADIO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKM RADIO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04175828
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KM RADIO LIMITED ?

    • Radiodiffusion (60100) / Information et communication

    Où se situe KM RADIO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Medway House Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4DU Strood
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KM RADIO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour KM RADIO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 juin 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mars 2016

    État du capital au 21 mars 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Duncan Gray en tant que secrétaire le 30 janv. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Sarah Hill en tant que secrétaire le 30 janv. 2016

    1 pagesTM02

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2015

    État du capital au 15 avr. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2014

    5 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mars 2014

    État du capital au 27 mars 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2012 au 30 juin 2013

    1 pagesAA01

    Inscription de la charge 041758280005

    51 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Nomination de Sarah Hill en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de * Messenger House New Hythe Lane, Larkfield Aylesford Kent ME20 6SG* le 22 juin 2012

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard Elliot en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de KM RADIO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRAY, Duncan
    Old Road West
    DA11 0LJ Gravesend
    Oban Lodge
    Kent
    England
    Secrétaire
    Old Road West
    DA11 0LJ Gravesend
    Oban Lodge
    Kent
    England
    205278320001
    ALLINSON, Geraldine Ruth Pratt
    Stone Stile
    Hart Hill Charing
    TN27 0HW Ashford
    Kent
    Administrateur
    Stone Stile
    Hart Hill Charing
    TN27 0HW Ashford
    Kent
    EnglandBritishCompany Director81172780001
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director40591070005
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    BritishCompany Director40591070005
    EMERY, Wendy Jill
    3 Warnford Gardens
    Loose
    ME15 6PH Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    3 Warnford Gardens
    Loose
    ME15 6PH Maidstone
    Kent
    BritishAssistant Cs57934630001
    HILL, Sarah
    Plough Wents Road
    Chart Sutton
    ME17 3RY Maidstone
    York House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Plough Wents Road
    Chart Sutton
    ME17 3RY Maidstone
    York House
    Kent
    United Kingdom
    British170092030001
    SMITHERS, James Brian
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    Secrétaire
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    British16069770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLUBLEY, Simon
    Richmond House
    School Road Charing
    TN20 0HU Ashford
    Kent
    Administrateur
    Richmond House
    School Road Charing
    TN20 0HU Ashford
    Kent
    United KingdomBritishExecutive Director79409730001
    DE CARLE, Gavin
    32 Saint Josephs Vale
    SE3 0XF London
    Administrateur
    32 Saint Josephs Vale
    SE3 0XF London
    BritishAssociate Director81293630001
    IRWIN, Simon Mark
    33 Clarke Crescent
    Kennington
    TN24 9SA Ashford
    Kent
    Administrateur
    33 Clarke Crescent
    Kennington
    TN24 9SA Ashford
    Kent
    BritishExecutive Director64827060001
    LEWIS, David Dean
    Old Caring
    Caring Road Leeds
    ME17 1TH Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Old Caring
    Caring Road Leeds
    ME17 1TH Maidstone
    Kent
    BritishPublishing Director37803230003
    SMITHERS, James Brian
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    Administrateur
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    EnglandBritishDirector16069770001
    WILLIAMS, Penelope Jane
    1 Royton Avenue
    ME17 2PS Lenham
    Kent
    Administrateur
    1 Royton Avenue
    ME17 2PS Lenham
    Kent
    United KingdomBritishHead Of Radio222750600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour KM RADIO LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    26 août 2016La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    KM RADIO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 juin 2013
    Livré le 05 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 13 janv. 2010
    Livré le 26 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Geraldine Ruth Pratt Allinson Elizabeth Lawson Cecilia Buchanan and Henry Boorman
    Transactions
    • 26 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2009
    Livré le 15 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Omnibus guarantee & set-off agreement
    Créé le 02 avr. 2009
    Livré le 15 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 01 avr. 2009
    Livré le 03 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 03 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0