BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04175866
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ?

    • Services de représentation médiatique (73120) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROMOTION SPACE LIMITED24 mars 200324 mars 2003
    CPL HOLDINGS LIMITED29 août 200129 août 2001
    PARTNERSHIPS@ LIMITED08 mars 200108 mars 2001

    Quels sont les derniers comptes de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2018

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2017

    12 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2016

    12 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2015

    11 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 28 mars 2014

    16 pages2.24B

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 oct. 2013

    13 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    8 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    35 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor Egginton House 25-28 Buckingham Gate London SW1E 6LD England* le 18 avr. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de * 7Th Floor South Artillery House 11-19 Artillery Row London London SW1P 1RT England* le 27 mars 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Ms Michelle De Young en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Soanes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sean Fay en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Sandfield House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AR* le 13 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 mars 2012

    État du capital au 22 mars 2012

    • Capital: GBP 1,188.61
    SH01

    Qui sont les dirigeants de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    British22089740001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    71518050017
    COCKSHUTT, Diane
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    British75151590001
    FAY, Sean Ernan
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    Administrateur
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    United KingdomIrish84925400001
    FUSCO, Robert
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    British105982320001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HOWARD, Peter
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish77112140001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Administrateur
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS DIRECTORS LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Administrateur désigné
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    900021490001

    BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to beocme due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 nov. 2009
    Livré le 13 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 14 juil. 2009
    Livré le 31 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 11 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)

    BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 avr. 2013Administration started
    28 mars 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    DateType
    28 mars 2014Commencement of winding up
    16 janv. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    proposed liquidator
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    proposed liquidator
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0