HILLARYS HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HILLARYS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04178425 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit 2 Churchill Park Private Road No 2 Colwick NG4 2JR Nottingham Nottinghamshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 1 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 041784250006 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Darren Hansel Lock en tant que directeur le 20 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 déc. 2017 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 40 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 02 oct. 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 26 sept. 2014 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Richard Thomas le 03 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Andrew Dalby en tant que directeur le 28 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 041784250006, créée le 01 août 2014 | 71 pages | MR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, David Mathew Aubrey | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire | United Kingdom | Australian | 110226830001 | |||||
| RISMAN, John Matthew | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire | United Kingdom | British | 107350020002 | |||||
| THOMAS, Andrew Richard | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 154618250003 | |||||
| DOBSON, Kevin Michael | Secrétaire | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | British | 95476170001 | ||||||
| NICHOLSON, James Brett | Secrétaire | Laurel House 351 Mapperly Plains NG3 5RS Nottingham Nottinghamshire | British | 99628210001 | ||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 | |||||||
| BURKE, David Richard Andrew | Administrateur | 4 Adams Court DE7 8YF Ilkeston Derbyshire | British | 61576180002 | ||||||
| DALBY, Simon Andrew | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 110227460002 | |||||
| DOBSON, Kevin Michael | Administrateur | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | United Kingdom | British | 95476170001 | |||||
| FERGUSON, Fiona Claire | Administrateur | Cleveland Cottage Main Street NG23 5BA Claypole Nottinghamshire | British | 55116100001 | ||||||
| HOLMES, Roger Anthony | Administrateur | 421 Flagstaff House 10 St George Wharf SW8 2LZ Vauxhall London | United Kingdom | British | 105159350001 | |||||
| LOCK, Darren Hansel | Administrateur | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131597650005 | |||||
| NICHOLSON, James Brett | Administrateur | Laurel House 351 Mapperly Plains NG3 5RS Nottingham Nottinghamshire | British | 99628210001 | ||||||
| PETROW, Steven | Administrateur | Flat 2 48 Lennox Gardens SW1X 0DJ London | United Kingdom | American | 96100200001 | |||||
| RUSSO, Lorenzo | Administrateur | Flat 19 17 Eccleston Place SW1W 9NF London | Italian | 96100220001 | ||||||
| SHANKS, Michael Anthony | Administrateur | Oakdene Main Street NG25 0UT Morton Nottinghamshire | British | 25653690004 | ||||||
| SNAPES, Michael Joseph | Administrateur | Low Hill Cottage Low Hill Road, Roydon CM19 5JN Harlow Essex | British | 64079340001 | ||||||
| WILDIG, Simon Roger | Administrateur | 21e Rydens Road KT12 3AB Walton On Thames Surrey | British | 75978900001 | ||||||
| HILLGATE NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018840001 | |||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Administrateur désigné | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillarys Blinds (Holdings) Limited | 30 juin 2016 | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Unit 2 Churchill Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HILLARYS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 01 août 2014 Livré le 04 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 21 juin 2007 Livré le 02 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A security agreement | Créé le 30 juil. 2004 Livré le 13 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined) | Créé le 08 mai 2001 Livré le 22 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the lender under the terms of any finance document (all terms as defined) | |
Brèves mentions All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined) | Créé le 08 mai 2001 Livré le 22 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the security trustee under the terms of any finance document (all terms as defined) | |
Brèves mentions All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 mai 2001 Livré le 21 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any finance party under or pursuant to any of the financing documents (including in particular under the guarantee). All terms as defined. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0