HILLARYS HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHILLARYS HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04178425
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 2 Churchill Park
    Private Road No 2 Colwick
    NG4 2JR Nottingham
    Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HILLGATE (223) LIMITED13 mars 200113 mars 2001

    Quels sont les derniers comptes de HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    1 pagesAA

    Satisfaction de la charge 041784250006 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Darren Hansel Lock en tant que directeur le 20 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 déc. 2017

    3 pagesAA01

    Résolutions

    Resolutions
    40 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    1 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 02 oct. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2016

    État du capital au 23 févr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 26 sept. 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2015

    État du capital au 17 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Richard Thomas le 03 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Simon Andrew Dalby en tant que directeur le 28 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 041784250006, créée le 01 août 2014

    71 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, David Mathew Aubrey
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United KingdomAustralian110226830001
    RISMAN, John Matthew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish107350020002
    THOMAS, Andrew Richard
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish154618250003
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Secrétaire
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    British95476170001
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    British99628210001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Secrétaire désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BURKE, David Richard Andrew
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    British61576180002
    DALBY, Simon Andrew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110227460002
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Administrateur
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    United KingdomBritish95476170001
    FERGUSON, Fiona Claire
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    British55116100001
    HOLMES, Roger Anthony
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    Administrateur
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    United KingdomBritish105159350001
    LOCK, Darren Hansel
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131597650005
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    British99628210001
    PETROW, Steven
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    Administrateur
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    United KingdomAmerican96100200001
    RUSSO, Lorenzo
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Administrateur
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Italian96100220001
    SHANKS, Michael Anthony
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    British25653690004
    SNAPES, Michael Joseph
    Low Hill Cottage
    Low Hill Road, Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Administrateur
    Low Hill Cottage
    Low Hill Road, Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    British64079340001
    WILDIG, Simon Roger
    21e Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    21e Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    British75978900001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Administrateur désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Administrateur désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HILLARYS HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    30 juin 2016
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement262951
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HILLARYS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 août 2014
    Livré le 04 août 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ares Management Limited
    Transactions
    • 04 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 21 juin 2007
    Livré le 02 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse, London Branch as Agent and Trustee for the Secured Creditors (Security Agent)
    Transactions
    • 02 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined)
    Créé le 08 mai 2001
    Livré le 22 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the lender under the terms of any finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited (The "Security Trustee") as the Generalpartner of Close Brothers Private Equity (UK) Fund Vi (the "Lender")
    Transactions
    • 22 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined)
    Créé le 08 mai 2001
    Livré le 22 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the security trustee under the terms of any finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Equity (UK) Fund Vi Acting by Its General Partner Closeinvestment Partners Limited (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 22 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2001
    Livré le 21 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under or pursuant to any of the financing documents (including in particular under the guarantee). All terms as defined.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee") Acting as Securitytrustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 21 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0