HDG2018 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHDG2018 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04180966
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HDG2018 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HDG2018 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HDG2018 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALLMARK DEVELOPMENTS GROUP LIMITED18 nov. 200818 nov. 2008
    NEWPORT PROPERTIES LIMITED16 mars 200116 mars 2001

    Quels sont les derniers comptes de HDG2018 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour HDG2018 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Norman Edward Ewen en tant que directeur le 18 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Norman Edward Ewen en tant que secrétaire le 18 janv. 2022

    1 pagesTM02

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement d'adresse du siège social de The Barn Monument Offices Maldon Road Woodham Mortimer, Maldon Essex CM9 6SN à Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE le 17 mai 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 11 mars 2021

    LRESEX

    Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2020

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Derek Everington le 01 juil. 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Hallmark Developments (Essex) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 avr. 2018

    2 pagesPSC02

    Notification de Hallmark Developments (Essex) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 avr. 2018

    2 pagesPSC02

    Cessation de Norman Edward Ewen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 avr. 2018

    1 pagesPSC07

    Cessation de Stephen Derek Everington en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 avr. 2018

    1 pagesPSC07

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name15 août 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Rachat d'actions propres.

    3 pagesSH03

    Cessation de la nomination de Barry Andrew Brown en tant que directeur le 04 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de Barry Andrew Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 avr. 2018

    1 pagesPSC07

    Période comptable actuelle prolongée du 31 juil. 2018 au 31 janv. 2019

    1 pagesAA01

    Annulation d'actions. État du capital au 04 avr. 2018

    • Capital: GBP 200
    4 pagesSH06

    Comptes de micro-entité établis au 31 juil. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de HDG2018 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVERINGTON, Stephen Derek
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Administrateur
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish89416910007
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Secrétaire
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    British28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Secrétaire
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    British10393450001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROWN, Barry Andrew
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish81596280001
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Administrateur
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Administrateur
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    EnglandBritish10393450001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HDG2018 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hallmark Developments (Essex) Limited
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    04 avr. 2018
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Acts In England & Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies Register In England & Wales
    Numéro d'enregistrement04744551
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Hallmark Developments (Essex) Ltd
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    04 avr. 2018
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies In England & Wales
    Numéro d'enregistrement04744551
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr Stephen Derek Everington
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 avr. 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Norman Edward Ewen
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 avr. 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Barry Andrew Brown
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 avr. 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    HDG2018 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rental income from shop unit 3 roche close rochford.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rental income from shop unit 2 roche close rochford.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rental income from shop unit 1 roche close rochford.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rental income from unit 1 block b roche close rochford.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rental income from unit 2 block b roche close rochford.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rental income from unit 3 block b roche close rochford.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal and general charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises shop unit 3 roche close rochford (also k/a 7 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal and general charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises shop unit 2 roche close rochford (also k/a 6 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal and general charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises shop unit 1 roche close rochford (also k/a 5 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal and general charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises unit 1 block b roche close rochford (also k/a 3 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal and general charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises unit 2 block b roche close rochford (also k/a 2 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal and general charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises unit 3 block b roche close rochford (aslo k/a 1 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 nov. 2004
    Livré le 04 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 04 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 nov. 2004
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at the rear of 3-7 heath drive gidea park romford essex t/n EGL446524.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HDG2018 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 mars 2021Commencement of winding up
    11 avr. 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    practitioner
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Paul Atkinson
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    practitioner
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0