BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED

BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04191304
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (7032) /

    Où se situe BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o JML BUSINESS SERVICES LTD
    25 Church Street
    GU7 1EL Godalming
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARKCOM PROPERTIES LIMITED27 avr. 200127 avr. 2001
    CAPSTANQUAY LIMITED30 mars 200130 mars 2001

    Quels sont les derniers comptes de BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 avr. 2011

    État du capital au 04 avr. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Catteshall Mill Catteshall Road Godalming Surrey GU7 1NJ Uk le 06 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Alexandra Caroline Mackay Haining le 06 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Haining le 06 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Alexandra Caroline Mackay Haining le 06 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Haining le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Joanna Mary Mackenzie Lee le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Alexandra Caroline Mackay Haining le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 30 juin 2008

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 juin 2007

    12 pagesAA

    Statuts

    6 pagesMA

    Statuts

    12 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed parkcom properties LIMITED\certificate issued on 24/05/07
    2 pagesCERTNM

    Qui sont les dirigeants de BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MACKENZIE LEE, Joanna Mary
    Brook Road
    Sandhills
    GU8 5UR Wormley
    Redlands
    Surrey
    England
    Secrétaire
    Brook Road
    Sandhills
    GU8 5UR Wormley
    Redlands
    Surrey
    England
    British15820670003
    HAINING, Alexandra Caroline Mackay
    Route De Jerbourg
    GY4 6BH St Martins
    Couin De Vacque
    Guernsey
    Administrateur
    Route De Jerbourg
    GY4 6BH St Martins
    Couin De Vacque
    Guernsey
    United KingdomBritishDirector105312650010
    HAINING, Andrew
    Route De Jerbourg
    GY4 6BH St Martins
    Couin De Vacque
    Guernsey
    Administrateur
    Route De Jerbourg
    GY4 6BH St Martins
    Couin De Vacque
    Guernsey
    GuernseyBritishInvestment Banker42196640021
    BARBOUR, Dominic James
    57a Highbury Hill
    N5 1SU London
    Secrétaire
    57a Highbury Hill
    N5 1SU London
    British55349040001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    BOTTS, John Chester
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    Administrateur
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    United KingdomAmericanInvestment Banker2943960001
    TRUSTY, Scott Norman
    5 Beach Lane
    GU2 4EN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    5 Beach Lane
    GU2 4EN Guildford
    Surrey
    EnglandBritishProperty Developer1882300016
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    BALMUIR DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over fixed deposit
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever 10
    Brèves mentions
    All moneys from time to time held to the credit of the mortgagor by the bank on account number 08379777, sort code 18-00-02 designated "coutts & company re: parkcom properties limited".
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a national grid science and technology laboratories, springfield drive, leatherhead t/nos. SY646634 and SY680242. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 17 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property with t/nos. SY646634 and SY680242 and the proceeds of sale thereof and all moneys to be received under any policy of insurance effected in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 17 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 05 nov. 2004
    Livré le 11 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a griffin house, west street, woking.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 29 oct. 2004
    Livré le 05 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Details of charged account(s) barclays bank PLC re parkcom properties limited business tracker account account number 90447099. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 24 oct. 2002
    Livré le 28 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 28 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 16 juil. 2002
    Livré le 22 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re parkcom properties limited business premium account number 90139076. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 août 2001
    Livré le 23 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents
    Brèves mentions
    All that f/h property at parkside business park quinton road coventry t/no WM746125. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 23 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 09 août 2001
    Livré le 11 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Any sums certified by the fit out employer's agent as properly due to the contractor pursuant to the fit out contract and paid by lsc to the contractor under the fit out contract in relation to the link or any part of of the fit out works carried out or completed on or within the property prior to the termination date
    Brèves mentions
    All that f/h property situate and k/a land and buildings at parkside business park quinton road coventry, all and singular the fixed machinery buildings erections and other fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • The Learning and Skills Council for England
    Transactions
    • 11 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge debenture
    Créé le 11 mai 2001
    Livré le 16 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any loan documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Guinness Mahon & Co Limited
    Transactions
    • 16 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0