FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED

FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04198505
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 avr. 2015

    État du capital au 23 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Richard Smith le 19 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Robert Taberner le 18 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Jude Kay en tant que directeur le 28 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dominic Kay en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Abigail Mattison en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Maureen Claire Royston le 22 mai 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 avr. 2014

    État du capital au 24 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* le 21 févr. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Maureen Claire Royston en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Calveley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ian Richard Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    15 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    33 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188573340001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Administrateur
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Administrateur
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishCompany Director181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Administrateur
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishChartered Accountant150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    BritishSolicitor145920530001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director107751890001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Administrateur
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCeo131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant38256680007
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Administrateur
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritishChief Executive131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Administrateur
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor145920530001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritishDirector145102120001
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director71527500002

    FOUR SEASONS HOMES NO. 5 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rhyme debenture
    Créé le 12 nov. 2004
    Livré le 30 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Scarlet Finance Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 nov. 2001
    Livré le 14 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known at weston park, macclesfield, cheshire t/no: CH380502. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 juil. 2001
    Livré le 06 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juil. 2001
    Livré le 02 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as croxteth park residential home altcross/moss way croxteth liverpool title number MS390057. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juil. 2001
    Livré le 02 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a warmley house nursing & residential home tower road north warmley bristol t/n AV232106. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juil. 2001
    Livré le 02 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as weston park macclesfield cheshire; ch 380502. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0