BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRADLEY DOUBLELOCK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04200304
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    • Fabrication d'autres matériels de transport n.d.a. (30990) / Industries manufacturières

    Où se situe BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRADLOCK LIMITED13 avr. 200113 avr. 2001

    Quels sont les derniers comptes de BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de South Warwickshire Business Park Kineton Road Southam Warwickshire CV47 0AL à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS le 19 oct. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 sept. 2017

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2016

    État du capital au 12 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Alan Patrick Sparkes en tant que secrétaire le 29 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Garner en tant que secrétaire le 29 févr. 2016

    2 pagesAP03

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Nomination de Mr David Garner en tant qu'administrateur le 04 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Roland Kober en tant que directeur le 15 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Harald Kober en tant que directeur le 15 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mai 2015

    État du capital au 14 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Lee Bott en tant que directeur le 04 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Herr Roland Kober en tant qu'administrateur le 07 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Herr Harald Kober en tant qu'administrateur le 07 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2015 au 31 déc. 2014

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de , Victoria Works, Victoria Street, Bingley Bradford, West Yorkshire, BD16 2NH le 18 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GARNER, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Secrétaire
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    206524510001
    EUSTACE, Peter John
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    United KingdomBritishEngineer189489200001
    GARNER, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant116835250001
    PHILLIPS, Paul James
    Mountwilliam Court
    Monksland
    Athlone
    12
    Roscommon
    Ireland
    Administrateur
    Mountwilliam Court
    Monksland
    Athlone
    12
    Roscommon
    Ireland
    IrelandIrishSales Manager129256380001
    HARRIS, Neil John
    18 High Wood
    LS29 8SB Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    18 High Wood
    LS29 8SB Ilkley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant218806190001
    MCCARTNEY, David
    Rockwood Baxter Wood
    Cross Hills
    BD20 8BB Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rockwood Baxter Wood
    Cross Hills
    BD20 8BB Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector30484660002
    SPARKES, Alan Patrick
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    189494840001
    SWEENEY, Martin Nicholas
    1 Valley Court
    Canal Road
    BD1 4SP Bradford
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    1 Valley Court
    Canal Road
    BD1 4SP Bradford
    West Yorkshire
    England
    British71306800001
    BOTT, Lee
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishSales Director171818420001
    BROOK, Martin
    Wesley Avenue
    Low Moor
    BD12 0NR Bradford
    50
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wesley Avenue
    Low Moor
    BD12 0NR Bradford
    50
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66515300002
    DUNN, John Alfred
    The White House Pool Bank
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EJ Otley
    W Yorks
    Administrateur
    The White House Pool Bank
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EJ Otley
    W Yorks
    EnglandBritishDirector18299760001
    EDWARDS, Steven
    Victoria Works
    Victoria Street
    BD16 2NH Bingley Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Victoria Works
    Victoria Street
    BD16 2NH Bingley Bradford
    West Yorkshire
    UkBritishDirector158888940001
    HARRIS, Neil John
    18 High Wood
    LS29 8SB Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    18 High Wood
    LS29 8SB Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant218806190001
    HARTLEY, John David Smith
    The Steadings
    Kildwick
    BD20 9AE Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Steadings
    Kildwick
    BD20 9AE Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant81028910001
    KOBER, Harald, Herr
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    GermanyGermanEngineer189489890001
    KOBER, Roland, Herr
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    GermanyGermanAccountant189490070001
    LAMBERT, Laurence Ivor John
    High Torr
    71 Blyth Road
    S81 0JR Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    High Torr
    71 Blyth Road
    S81 0JR Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector39430930001
    MCCARTNEY, David
    Rockwood Baxter Wood
    Cross Hills
    BD20 8BB Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Rockwood Baxter Wood
    Cross Hills
    BD20 8BB Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector30484660002
    O'HANRAHAN, Robert Michael
    220 Wickersley Road
    The Stag
    S60 4JR Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    220 Wickersley Road
    The Stag
    S60 4JR Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector59213360001
    SPENCER, Andrew John
    9 Ambler Way Amblerthorn
    Queensbury
    BD13 2NU Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Ambler Way Amblerthorn
    Queensbury
    BD13 2NU Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomEnglishSales Director55236890001
    TOWERS, Colin
    15a Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    15a Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical79826430001
    TOWERS, Colin
    15a Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    15a Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Director79826430001
    VAN SMIRREN, Peter Richard
    Victoria Works
    Victoria Street
    BD16 2NH Bingley Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Victoria Works
    Victoria Street
    BD16 2NH Bingley Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector151320690001
    FIELDBORNE LIMITED
    1 Valley Court
    Canal Road
    BD1 4SP Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Valley Court
    Canal Road
    BD1 4SP Bradford
    West Yorkshire
    67642920001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Al-Ko Kober Limited
    South Warwickshire Business Park, Kineton Road
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    06 avr. 2016
    South Warwickshire Business Park, Kineton Road
    Kineton Road
    CV47 0AL Southam
    South Warwickshire Business Park
    Warwickshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies England And Wales
    Numéro d'enregistrement00492005
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2011
    Livré le 07 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John David Smith Hartley
    Transactions
    • 07 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 29 mars 2011
    Livré le 31 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 31 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other trade debts and floating charge on proceeds of other trade debts
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 16 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the invoice discounting agreement made between the security holder and the company for the purchase of debts and their related rights and any agreement in variation of, or supplemental to, or substitution for such agreement or otherwise (all terms as defined)
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge any receivables purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement, including their related rights all amounts of indebtedness now or at any time due or becoming due to the company by way of floating charge such monies as the company may from time to time receive in respect of the other trade debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 15 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Industrial Estates (Scotland) Limited
    Transactions
    • 15 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 02 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The assets as described on the schedule attached to the form 395 together with any and all obligations guarantees and warranties.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 02 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land and buildings k/a victoria way bingley west yorkshire t/n wyk 64180. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 02 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BRADLEY DOUBLELOCK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 sept. 2017Commencement of winding up
    02 janv. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0