STADCO HOLDINGS LTD.
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STADCO HOLDINGS LTD. |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04215953 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STADCO HOLDINGS LTD. ?
| Adresse du siège social | International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STADCO HOLDINGS LTD. ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour STADCO HOLDINGS LTD. ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 15 oct. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark John Smith le 18 avr. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Paul Fisher le 18 avr. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW à International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE le 07 oct. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark John Smith en tant que secrétaire le 05 sept. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Hayhurst en tant que secrétaire le 05 sept. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 20 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Mark John Smith en tant qu'administrateur le 30 nov. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Paul Fisher en tant qu'administrateur le 30 nov. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gregory Ian Macleod en tant que directeur le 30 oct. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Gordon Hussey en tant que directeur le 30 nov. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL à Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW le 29 déc. 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 042159530006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STADCO HOLDINGS LTD. ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Mark John | Secrétaire | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | 213570940001 | |||||||
| FISHER, Christopher Paul | Administrateur | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 183747270001 | |||||
| SMITH, Mark John | Administrateur | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 124719430001 | |||||
| HAYHURST, Michael | Secrétaire | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | British | 15201970002 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Secrétaire | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | British | 10529040001 | ||||||
| OTHERS INTERESTS LTD | Secrétaire | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 103784950001 | |||||||
| COOK, Jonathan Charles | Administrateur | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | 72559760001 | ||||||
| HUSSEY, David Gordon | Administrateur | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | England | British | 131639570002 | |||||
| HUSSEY, David Gordon | Administrateur | Callingwood Lane Tatenhill DE13 9SH Burton-On-Trent Callingwood Hall Staffordshire United Kingdom | British | 131639570001 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Administrateur | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | United Kingdom | British | 10529040001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Administrateur | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Administrateur | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Administrateur | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORRISS, Andrew Stuart | Administrateur | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | England | British | 11643310001 | |||||
| ROACHE, David John | Administrateur | Fallowfield Badgers Lane CV35 0BY Lower Tysoe Warwickshire | United Kingdom | British | 40953790002 | |||||
| STERNE, Dermot Desmond | Administrateur | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | Uk | British | 96569780001 | |||||
| SWORD, John David | Administrateur | Chivel OX7 5TR Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 1600540001 | |||||
| WILLIS, David John | Administrateur | Damson Cottage Highfields SY4 5UN Wem Shropshire | British | 51085590002 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Administrateur | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| OFFSHELF LTD | Administrateur | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 42228870001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STADCO HOLDINGS LTD. ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acertec Engineering Limited | 06 avr. 2016 | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
STADCO HOLDINGS LTD. a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 29 août 2013 Livré le 06 sept. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 29 août 2013 Livré le 04 sept. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 nov. 2005 Livré le 01 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge | Créé le 28 févr. 2003 Livré le 06 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 févr. 2003 Livré le 06 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge of shares | Créé le 23 juil. 2002 Livré le 07 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental deed to the target group debenture | Créé le 23 juil. 2002 Livré le 07 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0