STADCO HOLDINGS LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTADCO HOLDINGS LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04215953
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STADCO HOLDINGS LTD. ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe STADCO HOLDINGS LTD. ?

    Adresse du siège social
    International House Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STADCO HOLDINGS LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OFFSHELF 282 LTD14 mai 200114 mai 2001

    Quels sont les derniers comptes de STADCO HOLDINGS LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour STADCO HOLDINGS LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 15 oct. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark John Smith le 18 avr. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Paul Fisher le 18 avr. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW à International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE le 07 oct. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Mark John Smith en tant que secrétaire le 05 sept. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael Hayhurst en tant que secrétaire le 05 sept. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mai 2016

    État du capital au 09 mai 2016

    • Capital: GBP 19,155,439
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    20 pagesAA

    Nomination de Mr Mark John Smith en tant qu'administrateur le 30 nov. 2015

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher Paul Fisher en tant qu'administrateur le 30 nov. 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gregory Ian Macleod en tant que directeur le 30 oct. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Gordon Hussey en tant que directeur le 30 nov. 2015

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL à Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW le 29 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 042159530006 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de STADCO HOLDINGS LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Secrétaire
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    213570940001
    FISHER, Christopher Paul
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Administrateur
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish183747270001
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Administrateur
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish124719430001
    HAYHURST, Michael
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Secrétaire
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    Secrétaire
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    British10529040001
    OTHERS INTERESTS LTD
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    103784950001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    HUSSEY, David Gordon
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Administrateur
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    EnglandBritish131639570002
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Administrateur
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MACLEOD, Gregory Ian
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Administrateur
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Administrateur
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Administrateur
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    STERNE, Dermot Desmond
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Administrateur
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    UkBritish96569780001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILLIS, David John
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    Administrateur
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    British51085590002
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    OFFSHELF LTD
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    42228870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STADCO HOLDINGS LTD. ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    06 avr. 2016
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement555532
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    STADCO HOLDINGS LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 août 2013
    Livré le 06 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Board of the Pension Protection Fund
    Transactions
    • 06 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 août 2013
    Livré le 04 sept. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 04 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 01 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    Transactions
    • 01 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 06 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 06 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge of shares
    Créé le 23 juil. 2002
    Livré le 07 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Known as Chase Manhattan International Limited) or Theother Finance Parties
    Transactions
    • 07 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to the target group debenture
    Créé le 23 juil. 2002
    Livré le 07 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly K/a Chase Manhattan International Limited)
    Transactions
    • 07 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0