RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04216794 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 7 pages | LIQ13 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Charles Lowe en tant qu'administrateur le 26 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Paul Nixon en tant que directeur le 26 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 déc. 2018 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination de Stephen Paul Nixon en tant qu'administrateur le 08 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew David Potter en tant que directeur le 08 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Dyllan Hook en tant que directeur le 08 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 26 sept. 2017
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2017 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 135 Bishopsgate London EC2M 3UR à 250 Bishopsgate London EC2M 4AA le 23 mars 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Grahame Stewart Young en tant qu'administrateur le 21 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Andrew David Potter en tant qu'administrateur le 21 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Pinfield en tant que directeur le 21 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Patrick Wood en tant que directeur le 25 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| YOUNG, Grahame Stewart | Administrateur | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | 170337440001 | |||||||||
| BARTLETT, Paul Eugene | Secrétaire | 16 Oster Street AL3 5JL St Albans Hertfordshire | British | 54206450004 | ||||||||||
| BARTLETT, Paul Eugene | Secrétaire | 16 Oster Street AL3 5JL St Albans Hertfordshire | British | 54206450004 | ||||||||||
| CASTRO, Marcos | Secrétaire | 2b St Johns Road RH1 6HF Redhill Surrey | Other | 109248350003 | ||||||||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Secrétaire | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Secrétaire | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Secrétaire | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| BATES, Christopher Stephen | Administrateur | Side Elms 1 Beaufort Close RH2 9DG Reigate Surrey | England | British | 122812830001 | |||||||||
| BOAG, Timothy John Donald | Administrateur | 23 St Georges Road St Margaret's TW1 1QS East Twickenham Middlesex | England | British | 62111350003 | |||||||||
| BOAG, Timothy John Donald | Administrateur | 78 Bushwood Road TW9 3BQ Richmond Surrey | British | 62111350002 | ||||||||||
| CARPENTER, Paul | Administrateur | Broadoak 4 Overhill Road CR8 2JD Purley Surrey | United Kingdom | British | 53756030002 | |||||||||
| CARPENTER, Paul | Administrateur | Broadoak 4 Overhill Road CR8 2JD Purley Surrey | United Kingdom | British | 53756030002 | |||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Administrateur | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Administrateur | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 England | United Kingdom | British | 148842310001 | |||||||||
| DUKE, Danny Andrew | Administrateur | Downsland Drive CM14 4JT Brentwood 1 England | England | British | 125950180001 | |||||||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Administrateur | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Administrateur | Flat 25 Boss House Boss Street SE1 2PS London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Administrateur | Flat 25 Boss House Boss Street SE1 2PS London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||||||
| GREENSHIELDS, John Fraser | Administrateur | Highfield House The Lane TN3 0RP Fordcombe Kent | British | 62806730003 | ||||||||||
| HOOK, Robert Dyllan | Administrateur | 90-100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | England | British | 155721570001 | |||||||||
| HOURICAN, John Patrick | Administrateur | 64 Alma Road AL1 3BL St. Albans Hertfordshire | Irish | 77547010001 | ||||||||||
| MOY, Neal St John | Administrateur | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 | ||||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Administrateur | EC2M 4AA London 250, Bishopsgate England | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PATTINSON, Simon Timothy | Administrateur | 23 Grange Road CM23 5NG Bishops Stortford Hertfordshire | British | 119347900001 | ||||||||||
| PINFIELD, Andrew | Administrateur | 135 Bishopsgate EC2M 3UR London 5th Floor | England | British | 187860320001 | |||||||||
| POTTER, Andrew David | Administrateur | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | Scotland | British | 187353880001 | |||||||||
| ROBERTSON, Iain Leith Johnston | Administrateur | 14 March Pines EH4 3PF Edinburgh | British | 52225140001 | ||||||||||
| ROBSON, Jeremy Godfrey | Administrateur | The Crossways Corseley Road TN3 9RT Groombridge East Sussex | British | 98782450001 | ||||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Administrateur | Berberry Drive 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton 10 Bedfordshire England | England | British | 111421900001 | |||||||||
| WHITBY, Peter James | Administrateur | Turner House Chalcot Square NW1 8YP London 36c | Uk | British | 76096790001 | |||||||||
| WIEDEMANN, Benoit Jonathan | Administrateur | The Royal Bank Of Scotland Bankside 2, 90-100 Southward Street SE1 0SW London The Royal Bank Of Scotland England | England | British | 148527460001 | |||||||||
| WOOD, Mark Patrick, Dr | Administrateur | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 176795610001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 avr. 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 29 juil. 2016 | 29 juil. 2016 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
RBS SPECIALISED PROPERTY INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0