C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED

C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04217352
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Second Floor
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BURFORD CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED29 juin 200129 juin 2001
    SPLINTERWAY LIMITED15 mai 200115 mai 2001

    Quels sont les derniers comptes de C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 04 déc. 2013

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 oct. 2013

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 avr. 2013

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 31 oct. 2012

    2 pages3.6

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2012

    État du capital au 11 juin 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 30 avr. 2012

    2 pages3.6

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Philip Andrew Bolton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 31 oct. 2011

    2 pages3.6

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 07 avr. 2011

    2 pages3.6

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Robinson le 14 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Paul le 14 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Bedell Secretaries Limited le 14 mai 2010

    2 pagesCH04

    legacy

    3 pagesLQ01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2008

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2007

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEDELL SECRETARIES LIMITED
    New Street
    St Helier
    JE2 3RA Jersey
    26
    British Isles
    Secrétaire
    New Street
    St Helier
    JE2 3RA Jersey
    26
    British Isles
    Forme juridiqueREGULATED - PRIVATE LIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleFINANCIAL SERVICES (JERSEY) LAW 1998
    Numéro d'enregistrement4704
    110726760006
    BOLTON, Philip Andrew
    New Street
    .
    JE2 3RA St Helier
    26
    Jersey
    British Isles
    Administrateur
    New Street
    .
    JE2 3RA St Helier
    26
    Jersey
    British Isles
    JerseyIrishDirector167366100001
    PAUL, Martin
    26 New Street
    St Helier
    JE2 3RA Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    26 New Street
    St Helier
    JE2 3RA Jersey
    Channel Islands
    British IslesBritishLawyer112940100001
    ROBINSON, Michael
    26 New Street
    St Helier
    Jersey Je2 3ra
    Channel Islands
    Administrateur
    26 New Street
    St Helier
    Jersey Je2 3ra
    Channel Islands
    JerseyBritishAccountant112228810001
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Secrétaire
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    BritishCompany Director59275730001
    WHITE, Teresa Catherine
    28 Saint Marks Road
    Olde Hanwell
    W7 2PW London
    Secrétaire
    28 Saint Marks Road
    Olde Hanwell
    W7 2PW London
    Irish65724350010
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ANDERSON, Randolph John
    Flat 5 Spanish Place Mansions
    6 Spanish Place
    W1U 3HZ London
    Administrateur
    Flat 5 Spanish Place Mansions
    6 Spanish Place
    W1U 3HZ London
    United KingdomBritishCompany Director65745670002
    COLE, Terence Shelby
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    Administrateur
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    United KingdomBritishCompany Director71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    Administrateur
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    United KingdomBritishCompany Director7128850001
    GLEEK, Julian
    47 Gloucester Square
    W2 2TQ London
    Administrateur
    47 Gloucester Square
    W2 2TQ London
    EnglandBritishCompany Director112192210001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Administrateur
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    United KingdomBritishCompany Director59275730001

    C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 01 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings on the north west side of cannon street, birmingham t/no WM332195. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 113 avr. 2010Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 107 déc. 2013Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 122 mars 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
    Floating charge
    Créé le 09 oct. 2001
    Livré le 13 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as burford city plaza shares 1 limited to the chargee and the lenders (or any of them) or any receiver under the charge and under the other finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(For Itself and as Trustee for and on Behalf Ofthe Lenders)
    Transactions
    • 13 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Thirteenth supplemental trust deed made between burford group limited, the existing charging subsidiaries, the company, the other nominee companies and law debenture trustees limited (the trustee) (supplemental to, inter alia, a trust deed (the principal deed) dated 14TH september 1994)
    Créé le 31 août 2001
    Livré le 19 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal of and interest on the original stock, the new stock and all other moneys payable or to become payable under or pursuant to or secured or intended to be secured by these presents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    By way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights present and future (including any uncalled capital).
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transactions
    • 19 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed between burford group limited (then known as burford group PLC), burford acquisition limited, burford (1994) limited and the trustee (then known as L.D.C. trustees limited)
    Créé le 14 sept. 1994
    Acquis le 31 août 2001
    Livré le 20 sept. 2001
    En cours
    Montant garanti
    The principal of and interest on the original stock, the new stock and all other monies payable under or pursuant to or secured or intended to be secured by these presents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all that land on the northwest side of cannon street, birmingham t/n WM332195 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto... See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transactions
    • 20 sept. 2001Enregistrement d'une acquisition (400)

    C.G.I.S. CITY PLAZA SHARES 1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Lerner
    10 Eagle Court
    EC1M 5QD London
    receiver manager
    10 Eagle Court
    EC1M 5QD London
    John David Barber
    Cushman & Wakefield Llp 43-45 Portman Square
    W1A 3BG London
    receiver manager
    Cushman & Wakefield Llp 43-45 Portman Square
    W1A 3BG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0