CAVANAGH GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAVANAGH GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04220482
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROOMCO (2574) LIMITED21 mai 200121 mai 2001

    Quels sont les derniers comptes de CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 10 Crown Place London EC2A 4FT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 10 Crown Place London EC2A 4FT à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 01 août 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 juil. 2014

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Andrew Steven Fay en tant que directeur le 08 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mai 2014

    État du capital au 28 mai 2014

    • Capital: GBP .01
    SH01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2013

    21 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Steven Fay le 02 oct. 2013

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 29 juil. 2013

    • Capital: GBP 0.01
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2012

    21 pagesAA

    Nomination de Mr Edward Becton Davis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Jessica Abigail Smith le 20 juin 2012

    2 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Steven Fay le 02 mai 2012

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CAVANAGH GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Jessica Abigail
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    162368540001
    CLARKE, Gillian Marjorie
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Legal, Compliance And Risk154546630001
    CURRY, Richard Ian
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer105013710002
    DAVIS, Edward Becton
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomAmericanCfo167180370001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    BritishFinance Director75225920001
    HAVERLAND MILLARD, Neill
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    Secrétaire
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    BritishCompany Director78246160002
    HENSON, Ian Robert
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    Secrétaire
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    BritishDirector134091530001
    MILLARD, Neill Haverland
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    Secrétaire
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    BritishDirector157323990001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Secrétaire
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    BritishCompany Director71468530002
    SMYTH, Robert Franklin
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    Secrétaire
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    BritishGroup Finance Director26738380001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    CAMPBELL, John William Duffus
    11 Cramond Glebe Gardens
    EH4 6NZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11 Cramond Glebe Gardens
    EH4 6NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director1075710001
    CHAMBERS, Paul Stuart
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Finance Officer172496620001
    FAY, Andrew Steven
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director194736380001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    BritishFinance Director75225920001
    GILLESPIE, Charles
    11 Garrick Avenue
    Mearnskirk
    G77 5GF Newton Mearns
    Glasgow
    Administrateur
    11 Garrick Avenue
    Mearnskirk
    G77 5GF Newton Mearns
    Glasgow
    Uk/ScotlandBritishDirector85654910001
    HAVERLAND MILLARD, Neill
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    Administrateur
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    BritishCompany Director78246160002
    HENSON, Ian Robert
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    Administrateur
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    EnglandBritishDirector134091530001
    HOGARTH, Paul Henry
    Withington Hall
    Holmes Chapel Road Lower Withington
    SK11 9DS Chelford
    Cheshire
    Administrateur
    Withington Hall
    Holmes Chapel Road Lower Withington
    SK11 9DS Chelford
    Cheshire
    BritishDirector12524640003
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director80537570001
    LILEY, Mark
    8 Camel Grove
    KT2 5GR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    8 Camel Grove
    KT2 5GR Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishCompany Director68176370001
    MENDEL, Steven Paul
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Wealth Management147059160001
    REDGROVE, Simon George
    Green Street Barn, Green Street
    Shipley
    RH13 8JP West Sussex
    Administrateur
    Green Street Barn, Green Street
    Shipley
    RH13 8JP West Sussex
    EnglandBritishCompany Director94696490001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Administrateur
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritishCompany Director71468530002
    SMYTH, Robert Franklin
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    Administrateur
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    EnglandBritishGroup Finance Director26738380001
    TIMMINS, Kenneth Douglas
    93 Craiglockhart Road
    EH14 1EP Edinburgh
    Midlothlian
    Administrateur
    93 Craiglockhart Road
    EH14 1EP Edinburgh
    Midlothlian
    United KingdomBritishDirector51800860002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    CAVANAGH GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Scottish shares pledge
    Créé le 27 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the shares and all rights, money or property of an income nature accruing on or payable or receivable in respect of any of the shares whether by way of dividend, distribution, interest or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 13 mai 2005
    Livré le 26 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,151.94 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The company charges to the landlord with full title guarantee its interest in the deposit and a separate designated interest-bearing account;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Horizon Technology Group PLC
    Transactions
    • 26 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Shares charge
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares representing at any time the entire issued share capital of ernst & young financial management limited all dividends interest and other distributions all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 2003
    Livré le 29 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    CAVANAGH GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 juil. 2014Commencement of winding up
    24 juil. 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0