CAVANAGH GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CAVANAGH GROUP LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04220482 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAVANAGH GROUP LIMITED ?
Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAVANAGH GROUP LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CAVANAGH GROUP LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour CAVANAGH GROUP LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 10 Crown Place London EC2A 4FT | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 10 Crown Place London EC2A 4FT à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 01 août 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Steven Fay en tant que directeur le 08 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2013 | 21 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Steven Fay le 02 oct. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
État du capital au 29 juil. 2013
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2012 | 21 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Edward Becton Davis en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Jessica Abigail Smith le 20 juin 2012 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Steven Fay le 02 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CAVANAGH GROUP LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Jessica Abigail | Secrétaire | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | 162368540001 | |||||||
CLARKE, Gillian Marjorie | Administrateur | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | England | British | Head Of Legal, Compliance And Risk | 154546630001 | ||||
CURRY, Richard Ian | Administrateur | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 105013710002 | ||||
DAVIS, Edward Becton | Administrateur | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | American | Cfo | 167180370001 | ||||
GARDNER, Douglas Charles | Secrétaire | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | Finance Director | 75225920001 | |||||
HAVERLAND MILLARD, Neill | Secrétaire | The Gables Dragons Lane RH13 8GD Shipley West Sussex | British | Company Director | 78246160002 | |||||
HENSON, Ian Robert | Secrétaire | Shawbury Lane Nr Shustoke B46 2RU North Warwickshire Oakside Shawbury Village | British | Director | 134091530001 | |||||
MILLARD, Neill Haverland | Secrétaire | The Gables Dragons Lane RH13 8GD Shipley West Sussex | British | Director | 157323990001 | |||||
SINNETT, Paul Martin | Secrétaire | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | British | Company Director | 71468530002 | |||||
SMYTH, Robert Franklin | Secrétaire | Tangier Road GU1 2DE Guildford 3 Surrey | British | Group Finance Director | 26738380001 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
CAMPBELL, John William Duffus | Administrateur | 11 Cramond Glebe Gardens EH4 6NZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Company Director | 1075710001 | ||||
CHAMBERS, Paul Stuart | Administrateur | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 172496620001 | ||||
FAY, Andrew Steven | Administrateur | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 194736380001 | ||||
GARDNER, Douglas Charles | Administrateur | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | Finance Director | 75225920001 | |||||
GILLESPIE, Charles | Administrateur | 11 Garrick Avenue Mearnskirk G77 5GF Newton Mearns Glasgow | Uk/Scotland | British | Director | 85654910001 | ||||
HAVERLAND MILLARD, Neill | Administrateur | The Gables Dragons Lane RH13 8GD Shipley West Sussex | British | Company Director | 78246160002 | |||||
HENSON, Ian Robert | Administrateur | Shawbury Lane Nr Shustoke B46 2RU North Warwickshire Oakside Shawbury Village | England | British | Director | 134091530001 | ||||
HOGARTH, Paul Henry | Administrateur | Withington Hall Holmes Chapel Road Lower Withington SK11 9DS Chelford Cheshire | British | Director | 12524640003 | |||||
LAST, Richard | Administrateur | The Leys Farm Banbury Road Great Tew OX7 4DL Chipping Norton Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 80537570001 | ||||
LILEY, Mark | Administrateur | 8 Camel Grove KT2 5GR Kingston Upon Thames Surrey | British | Company Director | 68176370001 | |||||
MENDEL, Steven Paul | Administrateur | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Wealth Management | 147059160001 | ||||
REDGROVE, Simon George | Administrateur | Green Street Barn, Green Street Shipley RH13 8JP West Sussex | England | British | Company Director | 94696490001 | ||||
SINNETT, Paul Martin | Administrateur | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | England | British | Company Director | 71468530002 | ||||
SMYTH, Robert Franklin | Administrateur | Tangier Road GU1 2DE Guildford 3 Surrey | England | British | Group Finance Director | 26738380001 | ||||
TIMMINS, Kenneth Douglas | Administrateur | 93 Craiglockhart Road EH14 1EP Edinburgh Midlothlian | United Kingdom | British | Director | 51800860002 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
CAVANAGH GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Scottish shares pledge | Créé le 27 nov. 2007 Livré le 11 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right, title and interest in and to the shares and all rights, money or property of an income nature accruing on or payable or receivable in respect of any of the shares whether by way of dividend, distribution, interest or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 13 mai 2005 Livré le 26 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti £50,151.94 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The company charges to the landlord with full title guarantee its interest in the deposit and a separate designated interest-bearing account;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Shares charge | Créé le 19 déc. 2003 Livré le 06 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The shares representing at any time the entire issued share capital of ernst & young financial management limited all dividends interest and other distributions all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 oct. 2003 Livré le 29 oct. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CAVANAGH GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0