COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED

COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04220587
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    • Activités d'administration publique générale (84110) / Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

    Où se situe COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARTNERSHIPS FOR HEALTH LIMITED 11 sept. 200111 sept. 2001
    INTERCEDE 1730 LIMITED21 mai 200121 mai 2001

    Quels sont les derniers comptes de COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    85 pagesAA

    Nomination de Ms Sylwia Kuteszko-Tranmer en tant qu'administrateur le 31 août 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew James Cooper en tant que directeur le 31 août 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen David Talboys en tant qu'administrateur le 01 mai 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2025 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Ian Simon Ailles en tant qu'administrateur le 14 avr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Alexander en tant que directeur le 31 mars 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Malcolm Douglas Twite en tant que directeur le 10 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    135 pagesAA

    Nomination de Mr Matthew James Cooper en tant qu'administrateur le 29 oct. 2024

    2 pagesAP01

    État du capital après une attribution d'actions au 18 sept. 2024

    • Capital: GBP 82,788,664
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 16 oct. 2024

    • Capital: GBP 82,788,664
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2024 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Eleanor Mason en tant qu'administrateur le 01 avr. 2024

    2 pagesAP01

    État du capital après une attribution d'actions au 25 mars 2024

    • Capital: GBP 80,038,142
    3 pagesSH01

    Cessation de la nomination de Ben Masterson en tant que directeur le 01 avr. 2024

    1 pagesTM01

    État du capital après une attribution d'actions au 18 déc. 2023

    • Capital: GBP 77,677,142
    3 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    118 pagesAA

    Nomination de Mr Eric Thierry Guillaume en tant qu'administrateur le 01 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter Cornforth en tant qu'administrateur le 01 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Geraldine Mary Strathdee en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charaanjit Kaur Yogeshbhai Patel en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2023 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    59 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 oct. 2022 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AILLES, Ian Simon
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish128695490001
    ARIF, Nafees
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish205771390001
    CORNFORTH, Peter
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish15813820010
    FARRINGTON CHADD, Wendy
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish285255660001
    GUILLAUME, Eric Thierry
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandFrench205578950002
    KUTESZKO-TRANMER, Sylwia
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish338776580001
    MASON, Catherine
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish262828280001
    MASON, Eleanor Lucy
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish322659450001
    TALBOYS, Stephen David
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish158182830001
    WILLIAMS, Richard Stephen
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish159819070001
    GOLDSTONE, David Lionel Alexander
    17 Clarence Road
    AL1 4NN St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    17 Clarence Road
    AL1 4NN St. Albans
    Hertfordshire
    British79020680002
    HAMBLEY, Elizabeth
    7 Lancaster Lodge
    83 Lancaster Road
    W11 1QH London
    Secrétaire
    7 Lancaster Lodge
    83 Lancaster Road
    W11 1QH London
    British74202140001
    MACGREGOR, Donald Roy, Dr
    63 High Street
    Ashwell
    SG7 5NP Baldock
    Hertfordshire
    Secrétaire
    63 High Street
    Ashwell
    SG7 5NP Baldock
    Hertfordshire
    British125583770001
    WARD, Lesley Anne
    169 Acton Lane
    W4 5HN London
    Secrétaire
    169 Acton Lane
    W4 5HN London
    British28874470001
    WEBSTER, Paul Barnaby
    25 Leconfield Avenue
    Barnes
    SW13 0LD London
    Secrétaire
    25 Leconfield Avenue
    Barnes
    SW13 0LD London
    British119602340002
    WILSON, Rebecca Claire Hartle
    154 Compass House
    Smugglers Way Wandsworth
    SW18 1DB London
    Secrétaire
    154 Compass House
    Smugglers Way Wandsworth
    SW18 1DB London
    British117878590001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    ALEXANDER, Robert
    Villiers Avenue
    KT5 8BD Surbiton
    6
    England
    Administrateur
    Villiers Avenue
    KT5 8BD Surbiton
    6
    England
    EnglandBritish119811910001
    BACON, John William
    Ventnor Villas
    BN3 3DD Hove
    3
    East Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Ventnor Villas
    BN3 3DD Hove
    3
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish157812400001
    BALDWIN, Richard Keith, Dr
    The Shaugh
    TN7 4DP Upper Hartfield
    East Sussex
    Administrateur
    The Shaugh
    TN7 4DP Upper Hartfield
    East Sussex
    United KingdomBritish37207590001
    BEER, Nigel Jonathan
    Thames Road
    Goring
    RG8 9AL Reading
    Southdene
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Thames Road
    Goring
    RG8 9AL Reading
    Southdene
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish122862210002
    BEHAN, David, Sir
    39 Manor Road
    Rusthall
    TN4 8UD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    39 Manor Road
    Rusthall
    TN4 8UD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish125810090001
    BELFIELD, Stuart Gary
    170 Maldon Road
    CO5 0PH Tiptree
    Essex
    Administrateur
    170 Maldon Road
    CO5 0PH Tiptree
    Essex
    British101630240001
    BICKNELL, Anthony Guy Kirsten
    9 Chelverton Road
    SW15 1RW London
    Administrateur
    9 Chelverton Road
    SW15 1RW London
    United KingdomBritish60914720001
    CLYNE, Patrick Joe
    Pinner View
    HA1 4QD Harrow
    70
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Pinner View
    HA1 4QD Harrow
    70
    Middlesex
    England
    EnglandBritish148568350001
    CLYNE, Patrick Joseph
    25 Brookfield Road
    Far Headingley
    LS6 4EJ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    25 Brookfield Road
    Far Headingley
    LS6 4EJ Leeds
    West Yorkshire
    British87643340001
    COATES, Peter Alexander
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritish78007040001
    COATES, Peter Alexander
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    15 The Drive
    CR5 2BL Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritish78007040001
    COLIN THOME, David Geoffrey, Professor
    Higher View
    Newton By Frodsham
    WA6 6TN Kingsley
    Cheshire
    Administrateur
    Higher View
    Newton By Frodsham
    WA6 6TN Kingsley
    Cheshire
    British99313660001
    CONROY, Bernadette Sarah
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish89070800002
    COOPER, Matthew James
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    United KingdomBritish331249000001
    DAY, Mark
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    Administrateur
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    England
    EnglandBritish157242280003
    EVERINGTON, Anthony Herbert, Dr
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    Administrateur
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    United KingdomBritish20579120001
    EVERINGTON, Anthony Herbert, Dr
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    Administrateur
    28 Rhondda Grove
    E3 5AP London
    United KingdomBritish20579120001
    FARLEY, George Peter
    6 Meriton Rise
    Hadleigh
    IP7 5SB Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    6 Meriton Rise
    Hadleigh
    IP7 5SB Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish123834510001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0