SETON HOUSE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSETON HOUSE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04230439
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SETON HOUSE GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SETON HOUSE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Restucturing One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SETON HOUSE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SETON HOUSE GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SETON HOUSE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de C/O Sof Investments Ltd 8 Hanover Street London W1S 1YQ à Kpmg Restucturing One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham West Midlands B4 6GH le 20 févr. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 févr. 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2014

    État du capital au 17 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    15 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 8 Hanover Street London W1S 1YQ England* le 28 janv. 2014

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Royal Bank of Scotland Equity Finance 12Th Floor 135 Bishopsgate London EC2M 3UR United Kingdom* le 28 janv. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Ian Mcgillivray en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Julian Asquith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael James Peter England en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alistair Stewart en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    16 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park Chertsey Surrey KT16 0RS* le 01 août 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Maureen Hodgkinson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2011

    31 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    27 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Nomination de Ian Mcgillivray en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robin Powell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Devanney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SETON HOUSE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ASQUITH, Julian
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Restucturing
    West Midlands
    Administrateur
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Restucturing
    West Midlands
    EnglandBritish148019420001
    ENGLAND, Michael James Peter
    Bishopsgate
    12th Floor
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Administrateur
    Bishopsgate
    12th Floor
    EC2M 3UR London
    135
    England
    United KingdomBritish180351910001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Secrétaire
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British68049770001
    DEVANNEY, William Gerard
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    British161785480001
    HODGKINSON, Maureen
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Secrétaire
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    British161953930001
    MCCASLIN, Stuart David, Mr
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    British1824650002
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Secrétaire
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3929802
    154778710001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Administrateur
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    United KingdomBritish38963210003
    BOWKETT, Alan John
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Croxton Park
    Croxton
    PE19 6SY St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish33301630002
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish70252730001
    CARTER, Paul Dennis
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish123148720001
    CASTON, Richard Charles Austin
    11 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    11 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish62682380001
    COATES, Scott Terrence
    41 Moray Place
    EH3 6BT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    41 Moray Place
    EH3 6BT Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish121474690001
    CULLINAN, Rory Malcolm
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    Administrateur
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    EnglandBritish149327390001
    DEVANNEY, William Gerard
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Administrateur
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    United KingdomBritish,Irish87628900001
    DILLON, Hohn Eamon
    25 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    25 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    British77697360001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Administrateur
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    British58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    FREER, Robert Ian
    67 Fox Hollies Road
    B76 2RN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    67 Fox Hollies Road
    B76 2RN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British65280490001
    GREGSON, Henry William
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    Administrateur
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    EnglandBritish141581500001
    JONES, Alan Wingate
    The Grange
    North Cadbury
    BA22 7BY Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    The Grange
    North Cadbury
    BA22 7BY Yeovil
    Somerset
    British4561920002
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    LEWIS, Eric James
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish75455450001
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish148271070001
    MCGILLIVRAY, Ian
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    United KingdomBritish170383130001
    POWELL, Robin Clive
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Administrateur
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    EnglandBritish83736400002
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Administrateur
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    Administrateur
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritish136538310002
    STEWART, Alistair Duncan
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    ScotlandBritish128116940001
    RBEF LIMITED
    42 St Andrew Square
    EH2 2AD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    42 St Andrew Square
    EH2 2AD Edinburgh
    Midlothian
    94883700001

    SETON HOUSE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2008
    Livré le 07 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 07 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between seton house group limited,seton house holdings limited,seton house acquisition limited and lehman commercial paper inc.
    Créé le 04 juil. 2001
    Livré le 23 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from any charging company or any obligor (both terms as defined) to the chargee under any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transactions
    • 23 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SETON HOUSE GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juil. 2016Dissolved on
    04 févr. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0