BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04232204 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Eynsham Hall North Leigh OX29 6PN Witney Oxfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN United Kingdom à 2nd Floor 31 Chertsey Street Guildford Surrey GU1 4HD | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN | 1 pages | AD03 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de St. Thomas's Church St. Thomas Street London SE1 9RY à Eynsham Hall North Leigh Witney Oxfordshire OX29 6PN le 27 nov. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Michelle Elizabeth Young en tant que secrétaire le 02 nov. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Raymond Miller en tant que secrétaire le 02 nov. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Alan Wood en tant que directeur le 26 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de David Raymond Miller en tant que secrétaire le 21 oct. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Andrew O'reilly en tant que secrétaire le 21 oct. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Barry John Bennett en tant que directeur le 30 juin 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2Nd Floor 2 City Place Beehive Ring Road Gatwick West Sussex RH6 0PA United Kingdom à Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG, Michelle Elizabeth | Secrétaire | North Leigh OX29 6PN Witney Eynsham Hall Oxfordshire United Kingdom | 203067550001 | |||||||
| UPTON, Richard | Administrateur | North Leigh OX29 6PN Witney Eynsham Hall Oxfordshire United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||
| KELLY, Anthony Brian | Secrétaire | 1 Cricketers Close Ashington RH20 3JQ Pulborough West Sussex | British | 66203340002 | ||||||
| MILLER, David Raymond | Secrétaire | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | 193073210001 | |||||||
| MILLS, Ronald Charles | Secrétaire | 12 The Warren CM12 0LW Billericay Essex | British | 2836970002 | ||||||
| O'REILLY, John Andrew | Secrétaire | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | 160046340001 | |||||||
| RUDD, Andrew James | Secrétaire | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | British | 138471350001 | ||||||
| SCOTT, Christopher Richard | Secrétaire | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | British | 81998190003 | ||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Secrétaire désigné | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||
| ACKERMAN, Stephen Carl | Administrateur | The Cottage Shenfield Green CM15 8NG Shenfield Essex | England | British | 154539780001 | |||||
| BENNETT, Barry John | Administrateur | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | United Kingdom | Irish | 14707370002 | |||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Administrateur | 68 Ravelston Dykes EH12 6HF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 34800860003 | |||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Administrateur | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||
| CULLINGFORD, David Edward | Administrateur | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | United Kingdom | British | 33796520003 | |||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Administrateur | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| DICKSON, Pamela Simone | Administrateur | 38 Belmont Gardens EH12 6JD Edinburgh | United Kingdom | Scottish | 91810830001 | |||||
| EYLES, Peter George | Administrateur | Cross Oak House Cross Oak Lane RH1 5RF Redhill Surrey | United Kingdom | British | 98648030001 | |||||
| ISAACS, Paul Samuel | Administrateur | Rosemead Woodhill Road CM3 4DY Danbury Essex | England | British | 141827450001 | |||||
| KELLY, Anthony Brian | Administrateur | 1 Cricketers Close Ashington RH20 3JQ Pulborough West Sussex | British | 66203340002 | ||||||
| MILLS, Ronald Charles | Administrateur | 12 The Warren CM12 0LW Billericay Essex | United Kingdom | British | 2836970002 | |||||
| SCOTT, Christopher Richard | Administrateur | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | England | British | 81998190003 | |||||
| WOOD, Martin Alan | Administrateur | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | United Kingdom | British | 149906140001 | |||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Administrateur désigné | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley Town Hall Limited | 14 sept. 2016 | North Leigh OX29 6PN Witney Eynsham Hall Oxfordshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 19 janv. 2005 Livré le 28 janv. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Br èves mentions Legal mortgage all estates or interest in the f/h l/h hanover international conference and training centre plaistow lane bromley t/n SGL539181 and the lodge 67 plaistow lane bromley t/n SGL622848 together with all buildings fixtures plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 17 juil. 2001 Livré le 31 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations of each obligor to the security trustee and the secured parties | |
Brèves mentions The f/h property k/a the butten building and the mansion house and land at sunbridge park, bromley, kent t/n SGL539181, the f/h property k/a the lodge, 67 plaisow lane, bromley t/n SGL622848. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0