BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED

BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04232204
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Eynsham Hall
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SUNDRIDGE PARK MANAGEMENT CENTRE LIMITED11 juin 200111 juin 2001

    Quels sont les derniers comptes de BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2016

    État du capital au 16 juin 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN United Kingdom à 2nd Floor 31 Chertsey Street Guildford Surrey GU1 4HD

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN

    1 pagesAD03

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name17 mai 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de St. Thomas's Church St. Thomas Street London SE1 9RY à Eynsham Hall North Leigh Witney Oxfordshire OX29 6PN le 27 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Michelle Elizabeth Young en tant que secrétaire le 02 nov. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Raymond Miller en tant que secrétaire le 02 nov. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Martin Alan Wood en tant que directeur le 26 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de David Raymond Miller en tant que secrétaire le 21 oct. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John Andrew O'reilly en tant que secrétaire le 21 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 juil. 2014

    État du capital au 31 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Barry John Bennett en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2Nd Floor 2 City Place Beehive Ring Road Gatwick West Sussex RH6 0PA United Kingdom à Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN

    1 pagesAD02

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 11 juin 2013

    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    YOUNG, Michelle Elizabeth
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Eynsham Hall
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Eynsham Hall
    Oxfordshire
    United Kingdom
    203067550001
    UPTON, Richard
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Eynsham Hall
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Eynsham Hall
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    KELLY, Anthony Brian
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    Secrétaire
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    British66203340002
    MILLER, David Raymond
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    Secrétaire
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    193073210001
    MILLS, Ronald Charles
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    Secrétaire
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    British2836970002
    O'REILLY, John Andrew
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    Secrétaire
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    160046340001
    RUDD, Andrew James
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    Secrétaire
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    British138471350001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Secrétaire désigné
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    ACKERMAN, Stephen Carl
    The Cottage
    Shenfield Green
    CM15 8NG Shenfield
    Essex
    Administrateur
    The Cottage
    Shenfield Green
    CM15 8NG Shenfield
    Essex
    EnglandBritish154539780001
    BENNETT, Barry John
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    Administrateur
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    United KingdomIrish14707370002
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    CULLINGFORD, David Edward
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    Administrateur
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    United KingdomBritish33796520003
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DICKSON, Pamela Simone
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    Administrateur
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    United KingdomScottish91810830001
    EYLES, Peter George
    Cross Oak House
    Cross Oak Lane
    RH1 5RF Redhill
    Surrey
    Administrateur
    Cross Oak House
    Cross Oak Lane
    RH1 5RF Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish98648030001
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Administrateur
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    KELLY, Anthony Brian
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    1 Cricketers Close
    Ashington
    RH20 3JQ Pulborough
    West Sussex
    British66203340002
    MILLS, Ronald Charles
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    Administrateur
    12 The Warren
    CM12 0LW Billericay
    Essex
    United KingdomBritish2836970002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    WOOD, Martin Alan
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    Administrateur
    St. Thomas's Church
    St. Thomas Street
    SE1 9RY London
    United KingdomBritish149906140001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Administrateur désigné
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Eynsham Hall
    Oxfordshire
    United Kingdom
    14 sept. 2016
    North Leigh
    OX29 6PN Witney
    Eynsham Hall
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement8810991
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 19 janv. 2005
    Livré le 28 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage all estates or interest in the f/h l/h hanover international conference and training centre plaistow lane bromley t/n SGL539181 and the lodge 67 plaistow lane bromley t/n SGL622848 together with all buildings fixtures plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and debenture
    Créé le 17 juil. 2001
    Livré le 31 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations of each obligor to the security trustee and the secured parties
    Brèves mentions
    The f/h property k/a the butten building and the mansion house and land at sunbridge park, bromley, kent t/n SGL539181, the f/h property k/a the lodge, 67 plaisow lane, bromley t/n SGL622848. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee Foritself and for Each of the Secured Parties
    Transactions
    • 31 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0