GOBOWLING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOBOWLING LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04236526
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOBOWLING LIMITED ?

    • Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. (93290) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe GOBOWLING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Communications Road
    Greenham Business Park
    RG19 6AB Newbury
    Berkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GOBOWLING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOWL BRITANNIA LIMITED18 juin 200118 juin 2001

    Quels sont les derniers comptes de GOBOWLING LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2022
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GOBOWLING LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au18 juin 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 juil. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au18 juin 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour GOBOWLING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2021

    10 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nils Olof Sahlgren le 17 juin 2022

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2020

    9 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nils Olof Sahlgren le 01 avr. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nils Olof Sahlgren le 25 nov. 2019

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de James Cowper Kreston Mill House, Overbridge Square Hambridge Lane Newbury Berkshire RG14 5UX England à 2 Communications Road Greenham Business Park Newbury Berkshire RG19 6AB le 09 janv. 2020

    1 pagesAD01

    Modification des détails de Gobowling Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov. 2019

    2 pagesPSC05

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Gobowling Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 juin 2019

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nils Olof Sahlgren le 17 juin 2019

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Atlantic House 1st Floor New Bond Street Mayfair London W1S 1RR à James Cowper Kreston Mill House, Overbridge Square Hambridge Lane Newbury Berkshire RG14 5UX le 20 mai 2019

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Qui sont les dirigeants de GOBOWLING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SAHLGREN, Nils Olof
    Communications Road
    Greenham Business Park
    RG19 6AB Newbury
    2
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Communications Road
    Greenham Business Park
    RG19 6AB Newbury
    2
    Berkshire
    England
    EnglandSwedishManaging Director76559830006
    BARRASS, Ian
    Greenmantle
    25 Linersh Wood Close
    GU5 0EG Bramley
    Surrey
    Secrétaire
    Greenmantle
    25 Linersh Wood Close
    GU5 0EG Bramley
    Surrey
    BritishFinance Director79958610007
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Secrétaire désigné
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    ASHBRIDGE, Arthur John Alexander
    4 Goodacre Drive
    Chandlers Ford
    SO53 4LG Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    4 Goodacre Drive
    Chandlers Ford
    SO53 4LG Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritishOperations Director79981010002
    BARRASS, Ian
    Greenmantle
    25 Linersh Wood Close
    GU5 0EG Bramley
    Surrey
    Administrateur
    Greenmantle
    25 Linersh Wood Close
    GU5 0EG Bramley
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director79958610007
    FIRST DIRECTORS LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Administrateur désigné
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GOBOWLING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gobowling Holdings Ltd
    Communications Road
    Greenham Business Park
    RG19 6AB Newbury
    2
    Berkshire
    England
    06 avr. 2016
    Communications Road
    Greenham Business Park
    RG19 6AB Newbury
    2
    Berkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleLimited
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement04407945
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    GOBOWLING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2011
    Livré le 05 janv. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hospitality Holdings Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 24 août 2007
    Livré le 04 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Units c & d collingwood retail park newgate lane hampshire t/no HP413811 by way of fixed charge, the plant machinery and fixtures and fittings, goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 août 2007
    Livré le 04 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land & buildings lying to the north west of court drive bedfordshire t/no BD170022. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • West Register (Investments) Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 18 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    £123,375.00 due or to become due from the company formerly k/a bowl britannia limited to the chargee
    Brèves mentions
    The amount credited to an interest bearing account opened by eskmuir properties PLC in the name of eskmuir properties PLC and gobowling limited with national westminster bank PLC and all money from time to time withdrawn from or paid into the account in accordance with the rent deposit deed dated 30 april 2002 including interest accruing thereon.
    Personnes ayant droit
    • Eskmuir Properties PLC
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of deposit
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 14 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as bowl britannia limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the interest of the company in a deposit account at national westminster bank PLC held by eskmuir properties PLC presently in the sum of £123,375.00.
    Personnes ayant droit
    • Eskmuir Properties PLC
    Transactions
    • 14 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a bowl britannia limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a the megabowl units c and d collingwood retail park newgate lane fareham hampshire t/n HP413811. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 10 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a bowl britannia limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a the megabowl (also k/a gx supabowl) court drive dunstable bedfordshire LU5 4JD t/n BD170022. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0