SAUFLON CL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSAUFLON CL LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04237587
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SAUFLON CL LIMITED ?

    • Fabrication d'instruments et fournitures médicaux et dentaires (32500) / Industries manufacturières

    Où se situe SAUFLON CL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Delta Park Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SAUFLON CL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONCAVEX LIMITED25 juil. 200225 juil. 2002
    TRENDLASER LIMITED20 juin 200120 juin 2001

    Quels sont les derniers comptes de SAUFLON CL LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 oct. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SAUFLON CL LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SAUFLON CL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 26 févr. 2025

    • Capital: GBP 1,004
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Mathieson le 01 oct. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2023

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Stephen Harty en tant que directeur le 31 janv. 2024

    1 pagesTM01

    État du capital au 26 sept. 2023

    • Capital: GBP 1,003
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 25/09/2023
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2022

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Agostino Ricupati en tant que directeur le 29 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian George Andrews en tant que directeur le 29 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 18 janv. 2018

    • Capital: GBP 1,001
    4 pagesRP04SH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 26 juil. 2022

    • Capital: GBP 1,003
    3 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2021

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2020

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2019

    21 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Agostino Ricupati le 10 oct. 2019

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kevin Paul Barrett en tant que directeur le 29 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SAUFLON CL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHESHIRE, Richard Michael
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant / Finance Director238722620001
    MATHIESON, Stephen
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director175560480002
    BROAD, Robert Andrew
    48 Hamble Lane
    Hamble
    SO31 4JS Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    48 Hamble Lane
    Hamble
    SO31 4JS Southampton
    Hampshire
    BritishChemist78192540001
    MAYNARD, John Charles
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    British8288150003
    MAYNARD, John Charles
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    BritishFinance Director8288150003
    STEWART, Philip Wilson
    68 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    68 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    New ZealanderAccountant88867620001
    SECRETARIAL LAW LIMITED
    Charter Court
    Third Avenue
    SO15 0AP Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Charter Court
    Third Avenue
    SO15 0AP Southampton
    Hampshire
    31358160005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Brian George
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United StatesAmericanCorporate Executive248411900001
    BARRETT, Kevin Paul
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector194491210001
    BROAD, Robert Andrew
    48 Hamble Lane
    Hamble
    SO31 4JS Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    48 Hamble Lane
    Hamble
    SO31 4JS Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishChemist78192540001
    DUNCAN, Alan
    10 Mays Lane
    Stubbington
    PO14 2ER Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    10 Mays Lane
    Stubbington
    PO14 2ER Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishQuality Assurance Manager78192470001
    ERARD, Francis
    9 Skylark Meadows
    PO15 6TJ Whiteley
    Hampshire
    Administrateur
    9 Skylark Meadows
    PO15 6TJ Whiteley
    Hampshire
    United KingdomSwissCompany Director101916610001
    GOLDEN, Randal Louis
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United StatesAmericanCorporate Executive248403710001
    HARTY, Mark Stephen
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishPresident, Europe175516440001
    HARTY, Mark Stephen
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishPresident Europe175516440001
    III, Albert George White
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Financial Officer224140510001
    KAUFMAN, Carol Rose
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanLegal Affairs80908120001
    MACCABEE, Gordon Frederick
    16 Pacific Close
    Ocean Village
    SO14 3TX Southampton
    Administrateur
    16 Pacific Close
    Ocean Village
    SO14 3TX Southampton
    BritishEngineer86449940002
    MARKHAM, Geoffrey Thomas
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant66493540002
    MARKHAM, Geoffrey Thomas
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant66493540001
    MATHIESON, Stephen
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director175560480001
    MATZ, Gregory Wayne
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    UsaAmericanCorporate Executive165444120001
    MAYNARD, John Charles
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director8288150003
    MAYNARD, John Charles
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Fox Hollow Heathway
    GU15 2EL Camberley
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director8288150003
    MCEVOY, Steven
    Rockingham
    Alpine Road Ashurst
    SO40 7AN Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Rockingham
    Alpine Road Ashurst
    SO40 7AN Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishOperations Manager86449440001
    MILLER, Gary Colin
    Welbeck Avenue
    SO17 1SS Highfield
    48
    Hampshire
    Administrateur
    Welbeck Avenue
    SO17 1SS Highfield
    48
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director135557750001
    PENFOLD, Nigel Anton
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant136803520005
    PENFOLD, Nigel Anton
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director136803520004
    RICUPATI, Agostino
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanCorporate Executive238719270002
    STEWART, Philip Wilson
    68 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    68 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandNew ZealanderAccountant88867620001
    WELLS, Alan Edward
    100 Thames Street
    TW16 6AG Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    100 Thames Street
    TW16 6AG Sunbury On Thames
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director8657050001
    WELLS, Alan Edward
    100 Thames Street
    TW16 6AG Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    100 Thames Street
    TW16 6AG Sunbury On Thames
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector8657050001
    WELLS, Bradley Elliot
    39 - 43 Monument Hill
    KT13 8RN Weybridge
    Belgrave House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    39 - 43 Monument Hill
    KT13 8RN Weybridge
    Belgrave House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director168480730001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAUFLON CL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Coopervision Lens Care Limited
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    England
    06 avr. 2016
    Concorde Way
    Segensworth North
    PO15 5RL Fareham
    Delta Park
    Hampshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement1071033
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SAUFLON CL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 juin 2013
    Livré le 20 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 20 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 juin 2013
    Livré le 13 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Security Beneficiary)
    Transactions
    • 13 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 02 juin 2010
    Livré le 03 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £695,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    CX000008 filling and closing machine ABP001 CX1204 ED4272 CX000009 verification system camera f amberopt CX1213 CX000010 injection moulding machine ARB001 CX1202 193095 for details of further equipment charged please refer to form MG01 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Equipment Finance Limited
    Transactions
    • 03 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 févr. 2007
    Livré le 27 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property known as 49 49A 51 AND53 york street twickham t/n SGL169956,the l/h property known as unit 3 mace industrial estate mace lane ashford kent,the l/h property known as unit 4 mace industrial estate mace lane ashford kent,for details of further properties charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sg-Bcp, Llc (Security Agent)
    Transactions
    • 27 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 août 2006
    Livré le 02 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 août 2002
    Livré le 17 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £9,000 and all other monies due or to become due from the company formerly known as trendlaser limited to the chargee
    Brèves mentions
    The interest of the company in the sum of £9,000.
    Personnes ayant droit
    • Favergill Limited
    Transactions
    • 17 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mars 2002
    Livré le 16 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0