SAUFLON CL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SAUFLON CL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04237587 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SAUFLON CL LIMITED ?
Adresse du siège social | Delta Park Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SAUFLON CL LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 oct. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 juil. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SAUFLON CL LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SAUFLON CL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 févr. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Mathieson le 01 oct. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2023 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Stephen Harty en tant que directeur le 31 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
État du capital au 26 sept. 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2022 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Agostino Ricupati en tant que directeur le 29 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Brian George Andrews en tant que directeur le 29 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 18 janv. 2018
| 4 pages | RP04SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 juil. 2022
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2021 | 22 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2020 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2019 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Agostino Ricupati le 10 oct. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Paul Barrett en tant que directeur le 29 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SAUFLON CL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHESHIRE, Richard Michael | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant / Finance Director | 238722620001 | ||||
MATHIESON, Stephen | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 175560480002 | ||||
BROAD, Robert Andrew | Secrétaire | 48 Hamble Lane Hamble SO31 4JS Southampton Hampshire | British | Chemist | 78192540001 | |||||
MAYNARD, John Charles | Secrétaire | Fox Hollow Heathway GU15 2EL Camberley Surrey | British | 8288150003 | ||||||
MAYNARD, John Charles | Secrétaire | Fox Hollow Heathway GU15 2EL Camberley Surrey | British | Finance Director | 8288150003 | |||||
STEWART, Philip Wilson | Secrétaire | 68 Barnards Hill SL7 2NZ Marlow Buckinghamshire | New Zealander | Accountant | 88867620001 | |||||
SECRETARIAL LAW LIMITED | Secrétaire | Charter Court Third Avenue SO15 0AP Southampton Hampshire | 31358160005 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ANDREWS, Brian George | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire | United States | American | Corporate Executive | 248411900001 | ||||
BARRETT, Kevin Paul | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | England | British | Director | 194491210001 | ||||
BROAD, Robert Andrew | Administrateur | 48 Hamble Lane Hamble SO31 4JS Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Chemist | 78192540001 | ||||
DUNCAN, Alan | Administrateur | 10 Mays Lane Stubbington PO14 2ER Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Quality Assurance Manager | 78192470001 | ||||
ERARD, Francis | Administrateur | 9 Skylark Meadows PO15 6TJ Whiteley Hampshire | United Kingdom | Swiss | Company Director | 101916610001 | ||||
GOLDEN, Randal Louis | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire | United States | American | Corporate Executive | 248403710001 | ||||
HARTY, Mark Stephen | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | England | British | President, Europe | 175516440001 | ||||
HARTY, Mark Stephen | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | England | British | President Europe | 175516440001 | ||||
III, Albert George White | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United States | American | Chief Financial Officer | 224140510001 | ||||
KAUFMAN, Carol Rose | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United States | American | Legal Affairs | 80908120001 | ||||
MACCABEE, Gordon Frederick | Administrateur | 16 Pacific Close Ocean Village SO14 3TX Southampton | British | Engineer | 86449940002 | |||||
MARKHAM, Geoffrey Thomas | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 66493540002 | ||||
MARKHAM, Geoffrey Thomas | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 66493540001 | ||||
MATHIESON, Stephen | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 175560480001 | ||||
MATZ, Gregory Wayne | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | Usa | American | Corporate Executive | 165444120001 | ||||
MAYNARD, John Charles | Administrateur | Fox Hollow Heathway GU15 2EL Camberley Surrey | England | British | Company Director | 8288150003 | ||||
MAYNARD, John Charles | Administrateur | Fox Hollow Heathway GU15 2EL Camberley Surrey | England | British | Finance Director | 8288150003 | ||||
MCEVOY, Steven | Administrateur | Rockingham Alpine Road Ashurst SO40 7AN Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Operations Manager | 86449440001 | ||||
MILLER, Gary Colin | Administrateur | Welbeck Avenue SO17 1SS Highfield 48 Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 135557750001 | ||||
PENFOLD, Nigel Anton | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | England | British | Accountant | 136803520005 | ||||
PENFOLD, Nigel Anton | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 136803520004 | ||||
RICUPATI, Agostino | Administrateur | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire United Kingdom | United States | American | Corporate Executive | 238719270002 | ||||
STEWART, Philip Wilson | Administrateur | 68 Barnards Hill SL7 2NZ Marlow Buckinghamshire | England | New Zealander | Accountant | 88867620001 | ||||
WELLS, Alan Edward | Administrateur | 100 Thames Street TW16 6AG Sunbury On Thames Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 8657050001 | ||||
WELLS, Alan Edward | Administrateur | 100 Thames Street TW16 6AG Sunbury On Thames Middlesex | United Kingdom | British | Director | 8657050001 | ||||
WELLS, Bradley Elliot | Administrateur | 39 - 43 Monument Hill KT13 8RN Weybridge Belgrave House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 168480730001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAUFLON CL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coopervision Lens Care Limited | 06 avr. 2016 | Concorde Way Segensworth North PO15 5RL Fareham Delta Park Hampshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SAUFLON CL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 17 juin 2013 Livré le 20 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 06 juin 2013 Livré le 13 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 02 juin 2010 Livré le 03 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti £695,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions CX000008 filling and closing machine ABP001 CX1204 ED4272 CX000009 verification system camera f amberopt CX1213 CX000010 injection moulding machine ARB001 CX1202 193095 for details of further equipment charged please refer to form MG01 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 févr. 2007 Livré le 27 févr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h property known as 49 49A 51 AND53 york street twickham t/n SGL169956,the l/h property known as unit 3 mace industrial estate mace lane ashford kent,the l/h property known as unit 4 mace industrial estate mace lane ashford kent,for details of further properties charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 août 2006 Livré le 02 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 09 août 2002 Livré le 17 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti £9,000 and all other monies due or to become due from the company formerly known as trendlaser limited to the chargee | |
Brèves mentions The interest of the company in the sum of £9,000. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mars 2002 Livré le 16 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0