WF REALISATIONS (2009) LIMITED

WF REALISATIONS (2009) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWF REALISATIONS (2009) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04251137
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WF REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    • (5242) /
    • (5243) /
    • (7123) /
    • (7487) /

    Où se situe WF REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WF REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WAREHOUSE FASHION LIMITED26 juil. 200126 juil. 2001
    FALLONPARK LIMITED12 juil. 200112 juil. 2001

    Quels sont les derniers comptes de WF REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 janv. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour WF REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 30 nov. 2011

    21 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2011

    21 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 mars 2011

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2010

    22 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2010

    22 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 mars 2010

    pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2009

    19 pages2.24B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed warehouse fashion LIMITED\certificate issued on 01/09/09
    2 pagesCERTNM

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    14 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    33 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    2 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 26 janv. 2008

    22 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages403b

    legacy

    2 pages403b

    Comptes annuels établis au 27 janv. 2007

    19 pagesAA

    legacy

    48 pages395

    legacy

    8 pages395

    legacy

    8 pages363a

    Qui sont les dirigeants de WF REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILKS, Jessica
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    Secrétaire
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    BritishInvestor Relations Manager116562380001
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Administrateur
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    United KingdomBritishDirector69669910005
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    Administrateur
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    EnglandBritishDirector40930620002
    SHEARWOOD, Mike
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector95093740001
    CASSAR, Stefan
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    Secrétaire
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    BritishCompany Director57039310004
    FLEETWOOD, Matthew David
    37 Hunts Field Close
    WA13 0SS Lymm
    Cheshire
    Secrétaire
    37 Hunts Field Close
    WA13 0SS Lymm
    Cheshire
    BritishDirector67509880002
    INMAN, Christopher
    Kingswood
    Kings Road
    HP8 4HN Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Kingswood
    Kings Road
    HP8 4HN Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishDirector117679910001
    STEVENSON, Rebecca Jayne
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    Secrétaire
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    British71917770002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BROWN, David Nigel
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant40354400003
    CASSAR, Stefan
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    Administrateur
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    BritishCompany Director57039310004
    DAVIES, Peter Wynne
    12 Highfield Drive
    UB10 8AN Ickenham
    Middlesex
    Administrateur
    12 Highfield Drive
    UB10 8AN Ickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector141625620001
    EGAN, John
    33 Broom Water
    TW11 9QJ Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    33 Broom Water
    TW11 9QJ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director123933290002
    GOLDMAN, Adam Alexander
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    Administrateur
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor28466260004
    HALL, Nigel Patrick
    9 Harmont House
    20 Harley Street
    W1N 1AL London
    Administrateur
    9 Harmont House
    20 Harley Street
    W1N 1AL London
    BritishFinance Director47504550003
    HEALEY, Mark Anthony
    Highfield House
    Highfield Lane, Woodlesford
    LS26 8RF Leeds
    Administrateur
    Highfield House
    Highfield Lane, Woodlesford
    LS26 8RF Leeds
    BritishChartered Accountant77432550001
    INMAN, Christopher
    Kingswood
    Kings Road
    HP8 4HN Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Kingswood
    Kings Road
    HP8 4HN Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector117679910001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Administrateur
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    BritishSolicitor71660800001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MCCARTHY, Donald
    2 Fairway Gardens
    Park Langley
    BR3 6YL Beckenham
    London
    Administrateur
    2 Fairway Gardens
    Park Langley
    BR3 6YL Beckenham
    London
    BritishCompany Director64482220002
    PETERSON, Alan Edward
    153 Cyncoed Road
    Cyncoed
    CF23 6AG Cardiff
    Administrateur
    153 Cyncoed Road
    Cyncoed
    CF23 6AG Cardiff
    BritishConsultant28231980002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RIVA, Hilary Susan
    5 Abbey Street
    ME13 7BE Faversham
    Kent
    Administrateur
    5 Abbey Street
    ME13 7BE Faversham
    Kent
    EnglandBritishDirector110262360001
    SIMS, Richard
    Saint Thomas Farm
    Carrick Hill
    TN21 9IL Dallington
    East Sussex
    Administrateur
    Saint Thomas Farm
    Carrick Hill
    TN21 9IL Dallington
    East Sussex
    BritishDirector75756460001

    WF REALISATIONS (2009) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge on shares
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 27 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, the derivative assets; all dividends see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Finance Parties)(in Such Capacity, the Security Trustee)
    Transactions
    • 27 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of accession
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 27 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 27 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Charge on shares
    Créé le 21 mai 2007
    Livré le 23 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, the derivative assets, all dividends interest and other income deriving from any stocks shares or other securities and all moneys income and amounts from all or any part of the shares or T. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 2006
    Livré le 21 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 21 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 02 févr. 2005
    Livré le 12 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 12 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2002
    Livré le 24 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The premium premises being warehouse limited 7 cathedral walk st davids centre cardiff t/n WA270359, principles retail limited 40 clarence street kingston-upon-thames t/n SGL639531 warehouse limited, unit 2, barker's arcade kensington high street london t/n NGL684701, for details of further properties charged please refer to the form 395, all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2002
    Livré le 24 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 oct. 2002
    Livré le 25 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £1,150,000 in an interest bearing account in the tenant's name and designated "cnw house deposit account".
    Personnes ayant droit
    • Turner Broadcasting System Europe Limited
    Transactions
    • 25 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 août 2002
    Livré le 12 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 2002
    Livré le 12 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    7 cathedral walk st david's centre cardiff, unit 2 barkers arcade kensington high street london title number NGL684701, unit L119 lower guidhall bluewater park. For further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (The "Securityagent")
    Transactions
    • 12 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WF REALISATIONS (2009) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mars 2009Administration started
    30 nov. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0