EURO WHOLESALE LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | EURO WHOLESALE LTD |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04256725 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EURO WHOLESALE LTD ?
Adresse du siège social | New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street EC4V 6BJ London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EURO WHOLESALE LTD ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour EURO WHOLESALE LTD ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 16 pages | LIQ14 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 sept. 2018 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 sept. 2017 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 sept. 2016 | 10 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 5 pages | 4.20 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ordonnance du tribunal S1096 Court Order to Rectify | 1 pages | OC | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 352 Bearwood Road Smethwick West Midlands B66 4ET à New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ le 23 sept. 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||
legacy | pages | ANNOTATION | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jhalman Singh Atwal en tant que directeur le 01 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Harinder Kaur Atwal en tant que secrétaire le 01 juin 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 37 Regal Drive, Walsall Enterprise Park Walsall West Midlands WS2 9HQ England à 352 Bearwood Road Smethwick West Midlands B66 4ET le 29 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jhalman Singh Atwal le 24 juil. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EURO WHOLESALE LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHERA, Charanjiv Singh | Administrateur | 30-34 New Bridge Street EC4V 6BJ London New Bridge Street House | England | British | Company Director | 77031260002 | ||||
ATWAL, Harinder Kaur | Secrétaire | Bearwood Road B66 4ET Smethwick 352 West Midlands England | British | Company Director | 66627580003 | |||||
CENTRAL SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Central House 582-586 Kingsbury Road B24 9ND Birmingham West Midlands | 70543540001 | |||||||
ATWAL, Jhalman Singh | Administrateur | Bearwood Road B66 4ET Smethwick 352 West Midlands England | England | British | Company Director | 77554790004 | ||||
KHERA, Kundan Singh | Administrateur | 37 Delves Road WS1 3JX Walsall West Midlands | England | British | Director | 81731400001 | ||||
CENTRAL DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Central House 582-586 Kingsbury Road B24 9ND Birmingham West Midlands | 70543530001 |
EURO WHOLESALE LTD a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Créé le 20 janv. 2010 Livré le 26 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from walsall vintners ltdto the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 35 enterprise park caldmore walsall with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 16 août 2006 Livré le 18 août 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property k/a unit 35 walsall enterprise park caldmore walsall. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 17 oct. 2005 Livré le 27 oct. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Unit 37 walsall enterprise park pleck caldmore walsall. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 19 juil. 2002 Livré le 30 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
EURO WHOLESALE LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0