THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04258762
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ?

    • (6523) /

    Où se situe THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THINC DESTINI TRAIL COLLECTIONS LIMITED18 juil. 200618 juil. 2006
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED29 avr. 200529 avr. 2005
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP PLC27 juin 200227 juin 2002
    GREENOAK MARKETING GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY30 août 200130 août 2001
    INDIGOHONEY PUBLIC LIMITED COMPANY25 juil. 200125 juil. 2001

    Quels sont les derniers comptes de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 29 déc. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account and other reserve be reduced to zero 22/12/2011
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    21 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Cessation de la nomination de Alasdair Mackay en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jeremy Peter Small le 23 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Nomination de Alasdair Mackay en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    BritishCompany Director67168210001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFinancial Director79136250001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Secrétaire
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    O'CONOR, Patrick Francis
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    Secrétaire
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    British50372870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    BritishDirector130449650001
    SMITH, Nicholas
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishSolicitor83415330001
    CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    98153140001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRISTOL, Teresa Louise
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    Administrateur
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    BritishManager83991510001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    EVERILL, Jonathan Robert Edwin
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    Administrateur
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    BritishIfa34156430003
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    Administrateur
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    BritishFinancial Adviser105488120003
    GALVIN WRIGHT, Jonathon William
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    Administrateur
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    BritishMarketing Director79499790001
    GRIFFITHS, Mark Roderick Winton
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    Administrateur
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    BritishSolicitor61034080001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    UkBritishCompany Director98560430001
    LUMSDEN COOK, Anthony James
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Administrateur
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishLloyds Underwriter78707170001
    MACKAY, Alasdair Iain
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishNone146368090001
    PARSONS, Barry Gilbert
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector91796850001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Operating Officer130449650001
    SCOTT, Graham Leslie
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishIndependent Financial Adviser78187980001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Administrateur désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 10 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential UK Services Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policy
    Créé le 04 juin 2003
    Livré le 21 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Scottish equitable policy no: L0194075832 dl (barry gilbert parsons). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policy
    Créé le 04 juin 2003
    Livré le 21 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Scottish equitable policy no: L0192175832 dt (david john collett). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 avr. 2003
    Livré le 09 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0