CARP (NW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARP (NW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04259182
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARP (NW) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CARP (NW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARP (NW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CENTER PARCS NW LIMITED19 sept. 200119 sept. 2001
    CARP (UK) 525 juil. 200125 juil. 2001

    Quels sont les derniers comptes de CARP (NW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au23 avr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CARP (NW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 avr. 2016

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 août 2015

    État du capital au 17 août 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 23 avr. 2015

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Inglett le 01 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2014

    État du capital au 11 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 avr. 2014

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 25 avr. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juil. 2013

    État du capital au 29 juil. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Peter Dalby le 17 avr. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Peter Dalby le 17 avr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 avr. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    51 pagesMG01
    Annotations
    DateAnnotation
    20 mars 2012This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Comptes pour une société dormante établis au 28 avr. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2010 au 22 avr. 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de CARP (NW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish83381250004
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish81617110003
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Secrétaire
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    BRIGGS, Hugh Alexander
    6 Austral Street
    Kennington
    SE11 4SJ London
    Secrétaire
    6 Austral Street
    Kennington
    SE11 4SJ London
    British79558350002
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    British78791890003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Secrétaire
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secrétaire
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    British138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Secrétaire
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Administrateur
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    DALBY, Martin Peter
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    British83381250001
    DALBY, Martin Peter
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    British83381250001
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Administrateur
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Administrateur
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Administrateur
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    Administrateur
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    United KingdomBritish93239900002
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Administrateur
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritish55841850004
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Administrateur
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Administrateur
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Administrateur
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Administrateur
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritish83244210001
    ROBERTSON, Stephen James
    1 Hereford House
    13 Lauriston Road
    SW19 4JJ London
    Administrateur
    1 Hereford House
    13 Lauriston Road
    SW19 4JJ London
    British78505200001
    ROBINSON, Anthony Martin
    5 Gorse Corner
    Townsend Drive
    AL3 5SH St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Gorse Corner
    Townsend Drive
    AL3 5SH St Albans
    Hertfordshire
    British55873860003
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Administrateur
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritish54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Administrateur
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    Administrateur
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    British103272700001

    CARP (NW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Borrower deed of charge
    Créé le 28 févr. 2012
    Livré le 20 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transactions
    • 20 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Intercreditor deed
    Créé le 19 juin 2007
    Livré le 05 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited
    Transactions
    • 05 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 nov. 2002
    Livré le 15 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed equitable charge all securities belonging to the company and by way of floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais (Acting as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries and Includes Anysuccessor Appointed by the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A supplemental debenture supplemental to a debenture (the "original debenture") dated 28 august 2001,as amended by a deed of amendment dated 18 september 2001
    Créé le 19 sept. 2001
    Livré le 26 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from any obligor (as defined) to any secured party (as defined) under the facility documents,the b term loan documents or the long term facility documentation (all terms as defined)
    Brèves mentions
    All right,title and interest into the real property,as defined, and the tangible moveable property,as defined,the accounts,as defined,intellectual property,goodwill and uncalled capital; all investments,monetary claims and proceeds of any insurance policy and all related rights thereon; all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CARP (NW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 avr. 2016Commencement of winding up
    29 mars 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0