THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED

THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04259727
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /

    Où se situe THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    North House
    17 North John Street
    L2 5EA Liverpool
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ESSZENCIA LIMITED31 août 200131 août 2001
    NEATSAIL LIMITED26 juil. 200126 juil. 2001

    Quels sont les derniers comptes de THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juil. 2010

    État du capital au 27 juil. 2010

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy Molloy le 26 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2009 au 31 mars 2010

    3 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2005

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages395

    legacy

    4 pages395

    legacy

    8 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2004

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Secrétaire
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    British41693730006
    SILVANO, Helen
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    British55343270002
    LEWIS, Carl Alexander
    Badgers Croft Caldy Wood
    Caldy
    CH48 2LT Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Badgers Croft Caldy Wood
    Caldy
    CH48 2LT Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish52633210001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Administrateur
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish41693730006
    MOLLOY, Timothy
    20 Knightsbridge Avenue
    CW9 8GE Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    20 Knightsbridge Avenue
    CW9 8GE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish75847410001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Administrateur
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    MASTERS, Michael David
    26 Bellpit Close
    Worsley
    M28 7XH Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    26 Bellpit Close
    Worsley
    M28 7XH Manchester
    Lancashire
    British77738080001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    LEWIS, Elaine
    Badgers Croft
    Caldy
    CH48 Wirral
    Administrateur
    Badgers Croft
    Caldy
    CH48 Wirral
    United KingdomBritish127496420001
    MASTERS, Michael David
    1 Stonewalls Rosemary Lane
    Burton Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    1 Stonewalls Rosemary Lane
    Burton Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Clwyd
    WalesBritish77738080002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H establishment medispa clinic, london road, adlington, macclesfield, t/no CH254445. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 févr. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal mortgage
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 01 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the customer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a land at london road, adlington, london, t/no CH254445. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank
    Transactions
    • 01 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 janv. 2003
    Livré le 29 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    £340,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a farra's restaurant and dean wood london road adlington and also liberty city bar and restaurant london road adlington t/n CH254445.
    Personnes ayant droit
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0