TRINITY TWO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRINITY TWO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04269342
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRINITY TWO LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe TRINITY TWO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    52 Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRINITY TWO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TRINITY TWO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Mark Richard Bourgeois en tant que directeur le 22 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2015

    État du capital au 20 août 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Charles Appleyard en tant que directeur le 03 mars 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Bryan Womack en tant que directeur le 15 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2014

    État du capital au 19 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Mark Richard Bourgeois en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Xavier Pullen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2013

    État du capital au 20 août 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Stuart Andrew Wetherly en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Falguni Desai en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Christopher Laxton en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Karen Fox en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TRINITY TWO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WETHERLY, Stuart Andrew
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Secrétaire
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    177526220001
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Administrateur
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritishChartered Surveyor52710005
    STAVELEY, Charles Andrew Rover
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant133771640001
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Secrétaire
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Secrétaire
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    APPLEYARD, Andrew Charles
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Administrateur
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    United KingdomBritishFund Manager131498200001
    BARBER, Martin
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    Administrateur
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    BritishCompany Director35534320006
    BOURGEOIS, Mark Richard
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Administrateur
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    EnglandBritishChartered Surveyor60776880004
    BOYLAND, Roger Michael
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    Administrateur
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    BritishChartered Accountant33984480006
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Administrateur
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritishCompany Director101932350001
    COPELAND, Anne Marie
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    Administrateur
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor87679960001
    CORAL, Lynda Sharon
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    BritishDirector Chartered Accountant34029880004
    FOX, Karen Julia
    The Roost
    Chinnor Road
    OX9 3QY Towersey
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Roost
    Chinnor Road
    OX9 3QY Towersey
    Oxfordshire
    BritishFund Manager116116000001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Administrateur
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritishChartered Surveyor76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    The Green
    Saxlingham
    NR15 1TH Nethergate
    Grove Farm House
    Norfolk
    Administrateur
    The Green
    Saxlingham
    NR15 1TH Nethergate
    Grove Farm House
    Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official198871760001
    LEWIS PRATT, Andrew
    34 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    Administrateur
    34 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    BritishChartered Surveyor & Director60050050002
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishFund Manager105566370001
    PATTERSON, Christopher Lindsay
    17 Chatsworth Avenue
    SW20 8JZ London
    Administrateur
    17 Chatsworth Avenue
    SW20 8JZ London
    BritishFund Manager86029780001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Administrateur
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritishCompany Director78912170008
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Administrateur
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritishChart Accountant32866350001
    WOMACK, Ian Bryan
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Administrateur
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritishChartered Surveyor33902000006
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Third Floor 90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    Administrateur
    Third Floor 90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    72502190001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    Administrateur
    90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    72502080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRINITY TWO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Trinity Aberdeen Limited
    The Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    One
    Channel Islands
    06 avr. 2016
    The Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    One
    Channel Islands
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementJersey
    Autorité légaleJersey Law
    Lieu d'enregistrementJfsc
    Numéro d'enregistrement80724
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    TRINITY TWO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge (security and intercreditor deed)
    Créé le 05 mai 2005
    Livré le 23 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the borrower or any other obligor or any limited obligor to the obligor security trustee or any of the other obligor secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H and l/h property, specified assets, book debts, obligor security group shares, intellectual property, insurances, obligor transaction documents, net rental income, agreements floating charge all undertaking property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited (For Itself and as Trustee for the Obligorsecured Creditors)
    Transactions
    • 23 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Obligor/issuer floating charge agreement
    Créé le 05 mai 2005
    Livré le 18 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, the borrower or (in the case of the obligors only)any other obligor or any limited obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge, the whole of its undertaking and all property assets and rights present and future (including all stock in trade f/h and l/h property and balance standing to the credit of any client accounts),. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Mall Funding PLC
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 9 may 2005 and
    Créé le 29 avr. 2005
    Livré le 12 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any and all of the obligors to each of or all of the obligor secured creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the trinity centre union street in the city and county of aberdeen, all and whole those parts of the ground floor first basement level second basement level and third basement level of the building known as 157 to 165 union street and number 9 bridge street aberdeen t/n ABN28158, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited (Obligor Security Trustee)
    Transactions
    • 12 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 april 2004 and
    Créé le 06 avr. 2004
    Livré le 30 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of the obligor to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming all and whole the trinity centre, union street in the city and county of aberdeen, t/n ABN28158;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 30 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 avr. 2004
    Livré le 16 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings to the south of main road romford (now k/a the dolphin centre) havering t/n EGL416981. L/h land and buildings lying to the north of western road romford (now k/a liberty ii shopping centre) havering t/n EGL347983. L/h land the upper deck car park mercury gardens romford t/n EGL435359 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee and Agentfor the Finance Parties
    Transactions
    • 16 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 20 oct. 2003
    Livré le 07 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All assets rights and property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Itselfand as Agent for the Finance Parties
    Transactions
    • 07 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 21ST march 2002
    Créé le 28 févr. 2002
    Livré le 06 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee as security trustee for the finance parties (all terms as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The trinity centre union street aberdeen t/no.ABN28158. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2002
    Livré le 20 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that leasehold land being broadway shopping centre broadway bexleyheath in the london borough of bexley t/n SGL553179, all that freehold land being land and buildings to the south of main road romford (now known as the dolphin centre) havering t/n EGL416981 and all that leasehold land being land and buildings lying to the north of western road romford (known as liberty ii shopping centre) havering EGL347983 (for further details of property charged see schedule 3 of form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties (The Security Trustee) and (Theagent)
    Transactions
    • 20 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security by capital and regional retail (northern) limited,registered in the land register of scotland on 30 december 1998
    Créé le 21 déc. 1998
    Acquis le 07 nov. 2001
    Livré le 23 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The whole structure on the south side of union bridge,aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (Formerly Midland Bank PLC)
    Transactions
    • 23 nov. 2001Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 14 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security by capital and regional retail (northern) limited,recorded in the general register of sasines (aberdeen) on 1 september 1998
    Créé le 25 août 1998
    Livré le 23 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The trinity centre,union st,city and county of aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (Formerly Midland Bank PLC)
    Transactions
    • 23 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0