BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED

BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04269887
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ashley House
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IMCO (372001) LIMITED14 août 200114 août 2001

    Quels sont les derniers comptes de BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Proposed strike off 21/03/2011
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 17 mars 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    legacy

    3 pagesMG02

    Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808290001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishCompany Director148459300001
    STONE, Janis Avril
    60 Station Drive
    HG4 1JA Ripon
    North Yorkshire
    Secrétaire
    60 Station Drive
    HG4 1JA Ripon
    North Yorkshire
    BritishSales Director65322290001
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Secrétaire
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British50767140001
    BEAUMONT, Terence Arthur
    Grange Park Boston Road
    LS22 5DY Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Grange Park Boston Road
    LS22 5DY Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCompany Director68602530001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Administrateur
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritishDirector91412650001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    BritishSolicitor72052540003
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishDirector9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director148459300001
    WICKS, Stephen Desmond
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director42298130002

    BURNSIDE MILL DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 09 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land at burnside mill main street addingham west yorkshire t/no WYK294391.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second legal charge
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 07 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to and under the terms of the joint venture agreement
    Brèves mentions
    F/H land and buildings situate and k/a burnside mill addingham west yorkshire fixed charges all copyright and all other intellectual property rights all book debts and other debts. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Cala Finance Limited
    Transactions
    • 07 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0