MSQ MARKETING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMSQ MARKETING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04273580
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MSQ MARKETING LIMITED ?

    • Études de marché et sondages d'opinion (73200) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MSQ MARKETING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MSQ MARKETING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ILLUMINAS LIMITED21 févr. 200621 févr. 2006
    INCEPTA MARKETING INTELLIGENCE LIMITED16 juil. 200316 juil. 2003
    INCEPTA SERVICE COMPANY LIMITED 03 oct. 200103 oct. 2001
    INTERCEDE 1738 LIMITED20 août 200120 août 2001

    Quels sont les derniers comptes de MSQ MARKETING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour MSQ MARKETING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed illuminas LIMITED\certificate issued on 28/01/16
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name28 janv. 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2015

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2015

    État du capital au 09 sept. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2014

    18 pagesAA

    Statuts

    22 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 042735800007 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2014

    État du capital au 20 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL England à C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ le 13 août 2014

    1 pagesAD01

    Inscription de la charge 042735800009, créée le 16 juil. 2014

    59 pagesMR01

    Inscription de la charge 042735800008, créée le 16 juil. 2014

    55 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2013

    17 pagesAA

    Inscription de la charge 042735800007

    17 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 août 2013

    État du capital au 27 août 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* le 27 août 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Daniel Yardley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de MSQ MARKETING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Secrétaire
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776410001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Administrateur
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishDirector147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Administrateur
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147343040001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Secrétaire
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Secrétaire
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Secrétaire
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BODEN, Andrew
    86 Sedley Close
    Parkwood
    ME8 9QY Rainham
    Kent
    Administrateur
    86 Sedley Close
    Parkwood
    ME8 9QY Rainham
    Kent
    BritishAssistant Company Secretary78382060001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector75720570001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Administrateur
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritishChartered Accountant76600500002
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director54128690003
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Administrateur désigné
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British900020860001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Administrateur
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Administrateur désigné
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British900019540001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Administrateur
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Administrateur
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    BritishDirector14119160001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MSQ MARKETING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Msq Holdings Limited
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    C/O Msq Partners Limited
    England
    06 avr. 2016
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    C/O Msq Partners Limited
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementUk (England) - Companies House
    Numéro d'enregistrement01382912
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MSQ MARKETING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 juil. 2014
    Livré le 21 juil. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited
    Transactions
    • 21 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 16 juil. 2014
    Livré le 18 juil. 2014
    En cours
    Brève description
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 sept. 2013
    Livré le 04 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 04 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental debenture
    Créé le 06 févr. 2012
    Livré le 23 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 08 déc. 2011
    Livré le 29 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 déc. 2011
    Livré le 20 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession deed
    Créé le 22 nov. 2005
    Livré le 05 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Créé le 12 août 2005
    Livré le 26 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Créé le 27 juil. 2005
    Livré le 04 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0