ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED

ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04274364
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    52 Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 sept. 2012

    État du capital au 06 sept. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Will Gowanloch Westbrook en tant qu'administrateur le 10 juil. 2012

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Krysto Archibald Milan Nikolic en tant que directeur le 10 juil. 2012

    2 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Jonathan Robson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Russell Black en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Corin Leonard Thoday en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 10 Lower Grosvenor Place London SW1W 0EN le 02 mars 2010

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 30/04/2009
    RES13

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    14 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    6 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Secrétaire
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    APPLEYARD, Andrew Charles
    55 Eton Rise
    Eton College Road
    NW5 2DQ London
    Administrateur
    55 Eton Rise
    Eton College Road
    NW5 2DQ London
    United KingdomBritish124838360001
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Administrateur
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritish52710005
    HAMILL, Luke
    Crystal Palace Road
    East Dulwich
    SE22 9JQ London
    227
    Administrateur
    Crystal Palace Road
    East Dulwich
    SE22 9JQ London
    227
    United KingdomBritish114139360002
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Administrateur
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    STAVELEY, Charles Andrew Rover
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish133771640001
    THODAY, Corin Leonard
    Norwich Road
    NR21 8AU Fakenham
    21
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Norwich Road
    NR21 8AU Fakenham
    21
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish138095630001
    WESTBROOK, Will Gowanloch
    St. Marys Grove
    W4 3LL London
    3
    Uk
    Administrateur
    St. Marys Grove
    W4 3LL London
    3
    Uk
    UkBritish170744070001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Secrétaire
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    BARBER, Martn
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    Administrateur
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    British77927440001
    BLACK, Russell Norman
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97983900003
    BOYLAND, Roger Michael
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    Administrateur
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    British33984480006
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Administrateur
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    CORAL, Lynda Sharon
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    British34029880004
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Administrateur
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritish52710005
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Administrateur
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LEWIS PRATT, Andrew
    61 Blandford Street
    W1U 7HR London
    Administrateur
    61 Blandford Street
    W1U 7HR London
    British60050050008
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Administrateur
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish105566370001
    NIKOLIC, Krysto Archibald Milan
    47-51 Gillingham Street
    SW1V 1HS London
    Flat 2 Sovereign Court
    Administrateur
    47-51 Gillingham Street
    SW1V 1HS London
    Flat 2 Sovereign Court
    UkBritish138589710001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Administrateur
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritish78912170008
    ROBSON, Jonathan
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    Administrateur
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    United KingdomBritish109313040002
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Administrateur
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritish32866350001
    WOMACK, Ian Bryan
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Administrateur
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritish33902000006
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Third Floor 90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    Administrateur
    Third Floor 90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    72502190001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    Administrateur
    90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    72502080001

    ST. ANDREWS QUAY TWO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 03 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H st andrews quay, kingston upon hull t/no. HS285820. By way of fixed charge the plant machinery, fixtures, fittings, furniture and equipment at the property. The goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property or charged assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for the Banks and as Security Trustee for the Finance Parties (The "Agent")
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for the Banks and as Security Trustee for the Finance Parties (The "Agent")
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal mortgage
    Créé le 07 nov. 2001
    Livré le 09 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and st andrews quay one limited to the chargee pursuant to a charge dated 17 january 2000
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a st andrews quay, kingston-upon hull, t/no HS285820.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0