THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED

THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04274612
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED ?

    • (9271) /

    Où se situe THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bentima House Lower Ground Floor
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPRING MOSS LIMITED21 août 200121 août 2001

    Quels sont les derniers comptes de THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2010

    État du capital au 22 sept. 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jose Luis Vasquez le 18 août 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 6 & 7 Princes Court Wapping Lane London E1W 2DA le 25 août 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jose Luis Vasquez le 18 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jose Luis Vasquez le 02 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Graham Andrew Duncan le 02 août 2010

    1 pagesCH03

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    13 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288c

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages287

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNCAN, Graham Andrew
    Lower Ground Floor
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Bentima House
    Secrétaire
    Lower Ground Floor
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Bentima House
    BritishAccountant131749410002
    VASQUEZ, Jose Luis
    Lower Ground Floor
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Bentima House
    Administrateur
    Lower Ground Floor
    168-172 Old Street
    EC1V 9BP London
    Bentima House
    United KingdomSpanishDirector131852120005
    APPS, Jonathan Michael Charles
    8 Paines Close
    HA5 3BN Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    8 Paines Close
    HA5 3BN Pinner
    Middlesex
    British,AustralianCompany Director71105860002
    GARLICK, Richard Paul
    15 Stone Gate Crescent
    LS7 2TD Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    15 Stone Gate Crescent
    LS7 2TD Leeds
    West Yorkshire
    British76718080001
    GORDON, Georgia Louise
    Flat 8 77-78 Warwick Square
    SW1V 2AR London
    Secrétaire
    Flat 8 77-78 Warwick Square
    SW1V 2AR London
    British83555480001
    HANCOCK, Simon Gregory John
    24 The Grove
    WD7 7NF Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    24 The Grove
    WD7 7NF Radlett
    Hertfordshire
    British104345230001
    JAMES, Richard Mark
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    BritishDirector77966860001
    JAMES, Richard Mark
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    BritishDirector77966860001
    WYCHERLEY, Charlotte Ann
    149 Jennyfield Drive
    HG3 2XQ Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    149 Jennyfield Drive
    HG3 2XQ Harrogate
    North Yorkshire
    British78144370001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    APPS, Jonathan Michael Charles
    8 Paines Close
    HA5 3BN Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    8 Paines Close
    HA5 3BN Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish,AustralianCompany Director71105860002
    DOCHERTY, David, Dr
    Sergehill House
    Sergehill Bedmond
    WD5 0RY Abbots Langley
    Herts
    Administrateur
    Sergehill House
    Sergehill Bedmond
    WD5 0RY Abbots Langley
    Herts
    United KingdomBritishCompany Director124089180002
    FEARON, Andrew Jason
    Brooms
    Langley Lower Green
    CB11 4SB Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Brooms
    Langley Lower Green
    CB11 4SB Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director69281370002
    HANCOCK, Simon Gregory John
    24 The Grove
    WD7 7NF Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    24 The Grove
    WD7 7NF Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant104345230001
    HUGHES, Mark Vaughan
    Longlands
    Knockholt Road, Halstead
    TN14 7ER Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Longlands
    Knockholt Road, Halstead
    TN14 7ER Sevenoaks
    Kent
    Northern IrelandBritishDirector142863710001
    JAMES, Richard Mark
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    Administrateur
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector77966860001
    MACDONALD, Neil Stirling
    36 Elstree Road
    Bushey Heath
    WD23 4GL Bushey
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Elstree Road
    Bushey Heath
    WD23 4GL Bushey
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director76876650001
    SWINGEWOOD, John Paul
    Rogers Farm
    Lunces Common
    RH16 4QU Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Rogers Farm
    Lunces Common
    RH16 4QU Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector141447260001
    WILKINSON, Peter Robert
    Sycamore Cottage Barrowby Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Sycamore Cottage Barrowby Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HD Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector4373790001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    THE GAMING CHANNEL BOOKMAKERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 août 2007
    Livré le 30 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Platinum Partners Value Arbitrage Fund, L.P. (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transactions
    • 30 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 19 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 26 juil. 2004
    Livré le 05 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 nov. 2001
    Livré le 21 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 21 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0