SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED

SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04275222
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED ?

    • Autres activités auxiliaires à l'assurance et au financement de la retraite (66290) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    20 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 sept. 2017

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 55 Gracechurch Street London EC3V 0RL à C/O Kpmg 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH le 27 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 05 sept. 2016

    LRESSP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gareth Richard Stewart Dickinson le 07 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 oct. 2015

    État du capital au 19 oct. 2015

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 55 Gracechurch Street London EC3V 0UF à 55 Gracechurch Street London EC3V 0RL le 16 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2013

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 sept. 2014

    État du capital au 04 sept. 2014

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 sept. 2013

    État du capital au 04 sept. 2013

    • Capital: GBP 200
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Stewart Carter le 19 août 2011

    2 pagesCH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROYAL LONDON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0RL London
    Secrétaire
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0RL London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04275222
    106736010001
    CARTER, Andrew Stewart
    Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    55
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    55
    United KingdomBritish145669000001
    CLIFFORD, Malory Peter
    49 Meadowbank
    NW3 3AY London
    Administrateur
    49 Meadowbank
    NW3 3AY London
    United KingdomBritish55730220001
    DICKINSON, Gareth Richard Stewart
    Gracechurch
    EC3V 0RL London
    55
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch
    EC3V 0RL London
    55
    United Kingdom
    United KingdomBritish133179560001
    SIOW, Alethea Chia Jung
    51 Manchester Street
    W1U 7LU London
    Administrateur
    51 Manchester Street
    W1U 7LU London
    EnglandBritish105292950001
    BARBER, Bernadette Clare
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Secrétaire
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    British81220720004
    STARR, Alison
    20 Goldhurst Terrace
    NW6 3HU London
    Secrétaire
    20 Goldhurst Terrace
    NW6 3HU London
    British77583120001
    BAILEY, Stuart Charles
    Farncombe House
    The Goodings
    RG17 7BD Woodlands St Mary
    Berkshire
    Administrateur
    Farncombe House
    The Goodings
    RG17 7BD Woodlands St Mary
    Berkshire
    EnglandBritish27669170002
    JAMES, Richard
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Administrateur
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    EnglandBritish81371430002
    MARTIN, Julia Helen
    8 Clifford Manor Road
    GU4 8AG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    8 Clifford Manor Road
    GU4 8AG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish142558830001
    NASH, William Robert
    Pyrton Cottage
    Little Missenden
    HP7 0RA Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pyrton Cottage
    Little Missenden
    HP7 0RA Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish77325240001
    PHILLIPS, Christopher Martin
    54 Grove Park Terrace
    W4 3QE London
    Administrateur
    54 Grove Park Terrace
    W4 3QE London
    British63912170002

    SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed relating to a debenture
    Créé le 18 août 2008
    Livré le 22 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H and l/h southpoint (formerly orbit house and now k/a palestra) 197 blackfriars road london t/nos LN84513 and TGL200933; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 22 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 oct. 2007
    Livré le 05 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H and l/h property k/a southpoint (formerly orbit house and now k/a palestra) 197 blackfriars road, london t/no's LN84513 and TGL200933, fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 05 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 oct. 2007
    Livré le 05 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H and l/h property k/a southpoint (formerly orbit house and now k/a palestra) 197 blackfriars road, london t/no's LN84513 and TGL200933, fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 05 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 17 sept. 2002
    Livré le 25 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent for the Lenders and the Securitytrustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 25 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of partnership interest
    Créé le 17 sept. 2002
    Livré le 25 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The partnership interest and the distributions including all monies payable to the company and any claims awards and judgements in favour of, receivable or received by the company under or in connection with or pursuant to the same. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent for the Lenders and the Securitytrustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 25 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    SOUTHPOINT GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 janv. 2019Due to be dissolved on
    05 sept. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    practitioner
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0